KELLER GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKELLER GROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02442580
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KELLER GROUP PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KELLER GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    2 Kingdom Street
    W2 6BD London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KELLER GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHIDWORTH LIMITED13 nov. 198913 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de KELLER GROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KELLER GROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation19 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour KELLER GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 323,754.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 avr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:

    • Capital: GBP 245,749.2
    2 pagesSH04

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 316,575
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 mars 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 302,286.8
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    25 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 311,746.7
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    25 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 297,420.1
    4 pagesSH03

    Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:

    • Capital: GBP 266,376.2
    2 pagesSH04

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 269,410.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 276,836.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 278,960.3
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 287,682.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 244,883.7
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 256,839.6
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 267,693.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 243,711.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 221,844.1
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 231,858.1
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Nomination de Catherine Elisabeth Shuttleworth en tant que secrétaire le 05 déc. 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kerry Anne Abigail Porritt en tant que secrétaire le 05 déc. 2025

    1 pagesTM02

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 208,631.1
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 215,067.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 204,217.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    25 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 194,240.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    24 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Déclaration de confirmation établie le 05 nov. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Peter Daniel Wroath le 18 août 2025

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de KELLER GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHUTTLEWORTH, Catherine Elisabeth
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Secrétaire
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    343235200001
    BELL, Paula
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United KingdomBritish250013820001
    BURKE, David Anthony
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    EnglandIrish134436150002
    FORSTER, Carl-Peter Edmund Moriz
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United KingdomBritish,German181063840001
    HERNANDEZ ABRAMS, Juan Gerardo
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United StatesAmerican292505690004
    KELLEHER, Annette Mary
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    EnglandIrish316936000001
    KING, Stephen Anthony, Mr
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United KingdomBritish87359440002
    ROCK, Kate Harriet Alexandra
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United KingdomBritish250008520001
    WROATH, James Peter Daniel
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    EnglandBritish261945030003
    ATKINSON, Justin Richard
    5 Top Farm Close
    HP9 1JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    5 Top Farm Close
    HP9 1JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British66680000001
    HOLMAN, Jacqueline Frances
    31 Radnor Avenue
    HA1 1SB Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    31 Radnor Avenue
    HA1 1SB Harrow
    Middlesex
    British44866630004
    PAINTING, Robert Philip
    5 Boultbee Road
    B72 1DW Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    5 Boultbee Road
    B72 1DW Sutton Coldfield
    West Midlands
    British9389800001
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Secrétaire
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    182945990001
    ATKINSON, Justin Richard
    12th Floor Capital House
    25 Chapel Street
    NW1 5DH London
    Administrateur
    12th Floor Capital House
    25 Chapel Street
    NW1 5DH London
    EnglandBritish66680000002
    BOND, Kevin Patrick, Dr
    The Wellhouse
    Clopton
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Wellhouse
    Clopton
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish168780840001
    BOND, Kevin Patrick, Dr
    The Wellhouse
    Clopton
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Wellhouse
    Clopton
    CV37 0QR Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish168780840001
    BROWN, Ernest Gerald Freeman
    Lily Rose 10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Lily Rose 10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    EnglandBritish60315730001
    CAIRNIE, Linda Ruth
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish151895420001
    DOBSON, Thomas
    1078 Foxcroft Run
    Annapolis Md21401
    Maryland Usa
    Administrateur
    1078 Foxcroft Run
    Annapolis Md21401
    Maryland Usa
    British56701410001
    EWEN, Robert John Tuch
    Batch Cottage
    Brockton
    TF13 6JR Much Wenlock
    Shropshire
    Administrateur
    Batch Cottage
    Brockton
    TF13 6JR Much Wenlock
    Shropshire
    United KingdomBritish49940200001
    FAIRSERVICE, Gavin Douglas
    Parr House 2 Wolsey Close
    Wimbledon
    SW20 0DD London
    Administrateur
    Parr House 2 Wolsey Close
    Wimbledon
    SW20 0DD London
    British2136240004
    FRANKLIN, Roy Alexander
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish119615970001
    GIRLING, Christopher
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish158770960002
    HILL, Peter John
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    United KingdomBritish182847960001
    HIND, James William George
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    United StatesBritish135701460002
    JIMENEZ, Pedro Jose Lopez
    Calle Nunez De Balboa 47 3b
    Madrid
    Spain
    Administrateur
    Calle Nunez De Balboa 47 3b
    Madrid
    Spain
    Spanish87074480001
    KIRSCH, Klaus
    Rheinstrasse 18
    D-6393 Wehrheim
    Germany
    Administrateur
    Rheinstrasse 18
    D-6393 Wehrheim
    Germany
    German20725320001
    LINDQVIST, Eva
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    Administrateur
    W2 6BD London
    2 Kingdom Street
    England
    SwedenSwedish119144620002
    MACPHERSON, Ronald Thomas Stewart, Sir
    27 Archery Close
    W2 2BE London
    Administrateur
    27 Archery Close
    W2 2BE London
    British49140580001
    MARTIN, Michael William Colin
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    British20930730002
    MICHAELIS, Maximillian Alain Philip
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish197998410001
    PAINTING, Robert Philip
    5 Boultbee Road
    B72 1DW Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    5 Boultbee Road
    B72 1DW Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish9389800001
    PAYNE, Keith Frederick
    58 Penton Road
    TW18 2LJ Staines
    Middlesex
    Administrateur
    58 Penton Road
    TW18 2LJ Staines
    Middlesex
    British59991390002
    PEIPERS, Harald
    Im Heidkamp 4
    D-45133 Essen
    Germany
    Administrateur
    Im Heidkamp 4
    D-45133 Essen
    Germany
    German47681440001
    RAJU, Vegesna Ranganadha, Dr
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    1 Sheldon Square
    W2 6TT London
    5th Floor
    England
    United KingdomSingaporean221628280003

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0