NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE

NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 02444362
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    • Éducation préprimaire (85100) / Enseignement

    Où se situe NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Adresse du siège social
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEWHAM WOMEN'S TRAINING AND EDUCATION CENTRE20 nov. 198920 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de C/O Linda Jordan 31 the Tanneries 9 Abbey Road London E15 3JZ England à C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 09 juin 2023

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 mai 2023

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Nicola Blatchly-Lewis le 17 mai 2023

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 19 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2021

    29 pagesAA

    Satisfaction de la charge 024443620006 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 19 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2020

    27 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 22 Deanery Road Stratford London E15 4LP à C/O Linda Jordan 31 the Tanneries 9 Abbey Road London E15 3JZ le 12 juil. 2021

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 19 nov. 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Elizabeth Laycock en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2020

    2 pagesPSC01

    Notification de Nicola Blatchly-Lewis en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2020

    2 pagesPSC01

    Notification de Linda Ann Jordan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2020

    2 pagesPSC01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 03 août 2020

    2 pagesPSC09

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Inscription de la charge 024443620006, créée le 02 juil. 2020

    31 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Statuts

    14 pagesMA

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2019

    26 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NELSON, Judith
    c/o Newham College
    High Street South
    E6 6ER London
    Newham College
    England
    Secrétaire
    c/o Newham College
    High Street South
    E6 6ER London
    Newham College
    England
    265165870001
    BLATCHLY-LEWIS, Nicola
    Manu Marble Way
    GL1 5QZ Gloucester
    36
    England
    Administrateur
    Manu Marble Way
    GL1 5QZ Gloucester
    36
    England
    EnglandBritishScitt:Early Year Programme Lead251726640002
    JORDAN, Linda Ann
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Administrateur
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    United KingdomBritishCivil Servant122623730001
    LAYCOCK, Elizabeth
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Administrateur
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    EnglandBritishManager133457980001
    DUNCAN, Jacqueline Colleen
    36 Claughton Road
    E13 9PN London
    Secrétaire
    36 Claughton Road
    E13 9PN London
    British23772830001
    EDWARDS, Patrick Lloyd
    22 Deanery Road
    Stratford
    E15 4LP London
    Secrétaire
    22 Deanery Road
    Stratford
    E15 4LP London
    BritishChief Executive54917440001
    GRANT, Caroline
    98a Chestnut Avenue
    Forest Gate
    E7 0JJ London
    Secrétaire
    98a Chestnut Avenue
    Forest Gate
    E7 0JJ London
    British73111130001
    MACDONALD, Maggie
    77 Listria Park
    N16 5SP London
    Secrétaire
    77 Listria Park
    N16 5SP London
    BritishConsultant62720370002
    MILLER, Norma Elizabeth, Professor
    Judes Gift
    105 Bow Road
    E3 2AN London
    Secrétaire
    Judes Gift
    105 Bow Road
    E3 2AN London
    BritishUniversity Lecturer71155730001
    BANKS, Hilary
    24 Ashley Hill
    BS6 5JG Bristol
    Administrateur
    24 Ashley Hill
    BS6 5JG Bristol
    BritishConsultant19665980003
    BARZEY, Daphne
    23 Mill Road
    Silverton
    E16 2BE London
    Administrateur
    23 Mill Road
    Silverton
    E16 2BE London
    BritishBricklayer23772940002
    BLOW, Anita
    54 Smiths Point
    E13 0NQ London
    Administrateur
    54 Smiths Point
    E13 0NQ London
    BritishStudent23772950001
    BOWN, Charles Nicholas
    Private & Confidential
    Newham Community College East Ham
    E6 4ER London
    Administrateur
    Private & Confidential
    Newham Community College East Ham
    E6 4ER London
    BritishAccountant57558440001
    BROWN, Denise Elizabeth
    22 Deanery Road
    Stratford
    E15 4LP London
    Administrateur
    22 Deanery Road
    Stratford
    E15 4LP London
    EnglandBritishManager185360260001
    BUSHAY, Paulette
    38 Lamberhurst Road
    RM8 1PS Dagenham
    Essex
    Administrateur
    38 Lamberhurst Road
    RM8 1PS Dagenham
    Essex
    BritishTraining & Development Manager49752120001
    CHIPPERFIELD, Marzieh
    Hamilton Court
    Maida Vale
    W9 1QR London
    Flat 17
    United Kingdom
    Administrateur
    Hamilton Court
    Maida Vale
    W9 1QR London
    Flat 17
    United Kingdom
    EnglandBritishManager73188170006
    CLARK, Geraldine
    Flat 1 8 Highbury Hill
    N5 1AL London
    Administrateur
    Flat 1 8 Highbury Hill
    N5 1AL London
    United KingdomOtherBarrister32364850002
    CORDERY, Jane Wendy
    63 Curling Lane
    Badgers Dene
    RM17 5JJ Grays
    Essex
    Administrateur
    63 Curling Lane
    Badgers Dene
    RM17 5JJ Grays
    Essex
    BritishBusiness Banking Manager39956670001
    EDWARDS, Linda
    28 Melbourne Road
    Walthamstow
    E17 6LR London
    Administrateur
    28 Melbourne Road
    Walthamstow
    E17 6LR London
    BritishTeacher56238010001
    EVANS, Christine
    14 Brookview Road
    SW16 6UA London
    Administrateur
    14 Brookview Road
    SW16 6UA London
    BritishManager45628070002
    FEAR, Ceryse Mary Diane
    30 Bullsbridge Road
    UB2 5LU Southall
    Middlesex
    Administrateur
    30 Bullsbridge Road
    UB2 5LU Southall
    Middlesex
    BritishLocal Government Officer75854090001
    FREESTONE, Christine
    Main Road
    RM2 6LS Romford
    123
    England
    Administrateur
    Main Road
    RM2 6LS Romford
    123
    England
    United KingdomBritishAssistant Principal - Hr And Legal125428230001
    GABBETT, Marilyn
    51 Capel Road
    Forest Gate
    E7 0JP London
    Administrateur
    51 Capel Road
    Forest Gate
    E7 0JP London
    BritishLecturer23772860001
    GOWLAND, Diane
    c/o Newham College
    High Street South
    East Ham
    E6 6ER London
    East Ham Campus
    England
    Administrateur
    c/o Newham College
    High Street South
    East Ham
    E6 6ER London
    East Ham Campus
    England
    United KingdomBritishPrincipal46643240002
    GREENWAY, Sarah Geraldine Elrose
    21 Carroll Close
    Stratford
    E15 1RS London
    Administrateur
    21 Carroll Close
    Stratford
    E15 1RS London
    BritishStudent58329650001
    ISHMAEL, Angela Elaine
    64 Drakefell Road Telegraph Hill
    Newcross
    SE14 5SJ London
    Administrateur
    64 Drakefell Road Telegraph Hill
    Newcross
    SE14 5SJ London
    BritishConsultant84398830002
    JOHNSON, Anne Hilary
    33 Blackheath Grove
    Blackheath
    SE3 0DH London
    Administrateur
    33 Blackheath Grove
    Blackheath
    SE3 0DH London
    United KingdomBritishPersonnel Manager160565480001
    KINGSLEY, Naomi Helen
    49 Northchurch Road
    N1 4EE London
    Administrateur
    49 Northchurch Road
    N1 4EE London
    EnglandBritishChief Executive71214910002
    KOTHARI, Jayesh Jamnadas Dayalji
    Acton Hill Mews, Uxbridge Road
    W3 9QN London
    1
    England
    Administrateur
    Acton Hill Mews, Uxbridge Road
    W3 9QN London
    1
    England
    United KingdomBritishAccountant230283040001
    LINEHAN, Dierdre
    33 Shrewsbury Road
    Forest Gate
    E7 8AJ London
    Administrateur
    33 Shrewsbury Road
    Forest Gate
    E7 8AJ London
    BritishAccountant23772840001
    MACARTHY, Genevieve
    37 Victoria Crescent
    N15 5LP London
    Administrateur
    37 Victoria Crescent
    N15 5LP London
    BritishCommunity Accountant43402230001
    MACDONALD, Maggie
    109 Clissold Crescent
    N16 9AS London
    Administrateur
    109 Clissold Crescent
    N16 9AS London
    BritishConsultant62720370001
    MCCARTHY, Sue
    52 Park Grove Road
    Leytonstone
    E11 4PU London
    Administrateur
    52 Park Grove Road
    Leytonstone
    E11 4PU London
    BritishLecturer23772850001
    MURPHY, Cherie Mary
    59 Hanameel Street
    E16 1UA London
    Administrateur
    59 Hanameel Street
    E16 1UA London
    BritishDepartment Assistant71215000001
    NAKUBUHIZI, Nadege
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    4th Floor
    England
    Administrateur
    25 Gresham Street
    EC2V 7HN London
    4th Floor
    England
    EnglandBritishRelationship Manager242739510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ms Linda Ann Jordan
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    30 juil. 2020
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Ms Nicola Blatchly-Lewis
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    30 juil. 2020
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Ms Elizabeth Laycock
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    30 juil. 2020
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    C/O Rsm Uk Restructuring Advisory Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    19 nov. 201630 juil. 2020La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 juil. 2020
    Livré le 03 juil. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Newtec college, 1 mark street, london, E15 4GY and as registered with the freehold title number EGL5381. Land at elliot close and mark street, stratford, london, E15 and as registered with the freehold title number EGL417576.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ortus Secured Finance I Limited
    Transactions
    • 03 juil. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 mai 2012
    Livré le 11 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The rent deposit of £30,000 paid under a rent deposit deed see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jawad Raza Khan and Chandrika Patel
    Transactions
    • 11 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 févr. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the f/h premises at 1 mark street, startford, london t/no EGL5381, by way of absolute assignment all the company's rights, title, interest and benefit in and to the rent.
    Personnes ayant droit
    • London Development Agency
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 01 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 mark street, stratford, london t/no EGL5381. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 09 déc. 1997
    Livré le 16 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 13 nov. 1995
    Livré le 25 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 juil. 2024Due to be dissolved on
    23 mai 2023Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas John Edwards
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0