PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED

PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02450698
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    • Gestion de la propriété résidentielle (98000) / Activités des ménages employeurs ; activités de production de biens et services non différenciées des ménages pour usage propre

    Où se situe PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Umberslade Business Centre Pound House Lane
    Hockley Heath
    B94 5DF Solihull
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WISESUPER LIMITED08 déc. 198908 déc. 1989

    Quels sont les derniers comptes de PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au08 déc. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation22 déc. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au08 déc. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael Juan Taylor en tant que directeur le 10 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2024

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2024 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2023

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Richard Phillip Casserley en tant qu'administrateur le 27 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Ashley Mason en tant que directeur le 27 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2022

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Windmill Paddocks Windmill Lane Hockley Heath Solihull West Midlands B94 6PT United Kingdom à Umberslade Business Centre Pound House Lane Hockley Heath Solihull B94 5DF

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Alexander James Russell en tant que directeur le 02 mars 2021

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alexander James Russell en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Craig Ashley Mason en tant qu'administrateur le 27 mars 2019

    2 pagesAP01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Windmill Paddocks Windmill Lane Packwood Solihull West Midlands B94 6PT à Umberslade Business Centre Pound House Lane Hockley Heath Solihull B94 5DF le 20 déc. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Peter Frederick Bradford en tant que directeur le 28 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Juan Taylor en tant qu'administrateur le 28 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASSERLEY, Richard Phillip
    Tillington Close
    B98 0NG Redditch
    50
    England
    Administrateur
    Tillington Close
    B98 0NG Redditch
    50
    England
    EnglandEnglish66153570005
    SPARKES, Richard Henry
    Greville Smith Avenue
    Whitnash
    CV31 2HQ Leamington Spa
    61
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Greville Smith Avenue
    Whitnash
    CV31 2HQ Leamington Spa
    61
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish194103120001
    BAKER, Paul
    2 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    2 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668590001
    COOK, Timothy
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668660001
    MARSHALL, Victoria
    21 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    21 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British73629480001
    MILLER, Paul Gregory
    28 Swinbrook Way
    Shirley
    B90 3LZ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    28 Swinbrook Way
    Shirley
    B90 3LZ Solihull
    West Midlands
    British29784400001
    TAYLOR, Michael Juan
    The School House
    Shepherd Street, Marton
    CV23 9RW Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    The School House
    Shepherd Street, Marton
    CV23 9RW Rugby
    Warwickshire
    British67742340001
    BAKER, Paul
    2 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    2 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668590001
    BALL, Alistair Henry Ian
    36 Prince Regent Court
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    36 Prince Regent Court
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British108916770001
    BOX, William
    Meadowcrest
    Coopers Hill
    B48 7BX Alvechurch
    Worcester
    Administrateur
    Meadowcrest
    Coopers Hill
    B48 7BX Alvechurch
    Worcester
    British16898020002
    BRADFORD, Peter Frederick
    Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Flat 10
    Warwickshire
    Administrateur
    Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Flat 10
    Warwickshire
    EnglandBritish136273160001
    BROPHY, Helen Mary
    22 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    22 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668490001
    CHAMLEY, Jacqueline
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British67513730001
    COOK, Timothy
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    18 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668660001
    MARSHALL, Victoria
    21 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    21 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish73629480001
    MASON, Craig Ashley
    The Quarter
    Egerton Street
    CH1 3NL Chester
    Apartment 60
    United Kingdom
    Administrateur
    The Quarter
    Egerton Street
    CH1 3NL Chester
    Apartment 60
    United Kingdom
    United KingdomBritish274570960001
    MERRITT, Spencer Lee
    8 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    8 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British60507110001
    MILLER, Paul Gregory
    28 Swinbrook Way
    Shirley
    B90 3LZ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    28 Swinbrook Way
    Shirley
    B90 3LZ Solihull
    West Midlands
    British29784400001
    MOORE, Angela Clare
    26 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    26 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British67742270001
    MUNRO, Pamela Jane
    Flat 36 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Flat 36 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British73629470001
    ROSE, Paul Eric
    Windmill Paddocks
    Windmill Lane Packwood
    B94 6PT Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Windmill Paddocks
    Windmill Lane Packwood
    B94 6PT Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish84624520001
    ROSE, Paul Eric
    33 Prince Regent Court
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    33 Prince Regent Court
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish84624520001
    RUSSELL, Alexander James
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    25 Prince Regent Court
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    25 Prince Regent Court
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish274571730001
    SKINNER, Christopher James
    9 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    9 Prince Regent Court
    Charlotte Street
    CV31 3RU Leamington Spa
    Warwickshire
    British47668450001
    TAYLOR, Michael Juan
    Shepherd Street
    Marton
    CV23 9RW Rugby
    The School House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Shepherd Street
    Marton
    CV23 9RW Rugby
    The School House
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish67742340001
    TAYLOR, Michael Juan
    The School House
    Shepherd Street, Marton
    CV23 9RW Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The School House
    Shepherd Street, Marton
    CV23 9RW Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish67742340001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PRINCE REGENT COURT (LEAMINGTON SPA) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0