PITSEC LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PITSEC LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02451677 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PITSEC LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4th Floor, Aquis House Blagrave Street RG1 1PL Reading England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PITSEC LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PITSEC LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PITSEC LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, the Anchorage Bridge Street Reading RG1 2LU England à 4th Floor, Aquis House Blagrave Street Reading RG1 1PL le 26 janv. 2026 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jeremy Michael Davy en tant que directeur le 02 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 2 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Bdb Pitmans Llp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 déc. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 2 pages | AA | ||
Modification des détails de Bdb Pitmans Llp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 avr. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Christopher Hutchinson le 29 avr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Suzanne Kay Brooker en tant que directeur le 30 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Sarah Potter en tant qu'administrateur le 10 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Delphine Nathalie Lydie Mehouas en tant que directeur le 15 nov. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Jeremy Michael Davy en tant qu'administrateur le 10 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Marcus Mccluggage en tant qu'administrateur le 10 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Christopher Netiatis en tant que directeur le 29 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de David Jeremy Hosford en tant que directeur le 27 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 2 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de David Birdwood Archer en tant que directeur le 27 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Ferhat Jehangeer Choudri en tant que directeur le 11 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de PITSEC LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHINSON, John Christopher | Secrétaire | Blagrave Street RG1 1PL Reading 4th Floor, Aquis House England | British | 40949150003 | ||||||
| HUTCHINSON, John Christopher | Administrateur | Blagrave Street RG1 1PL Reading 4th Floor, Aquis House England | United Kingdom | British | 40949150004 | |||||
| MCCLUGGAGE, Marcus | Administrateur | Blagrave Street RG1 1PL Reading 4th Floor, Aquis House England | England | British | 302276230001 | |||||
| POTTER, Sarah | Administrateur | Blagrave Street RG1 1PL Reading 4th Floor, Aquis House England | England | British | 302294840001 | |||||
| AIRD, Robert Service | Secrétaire | Frith Cottage Wolverton Common RG26 5RY Basingstoke Hampshire | British | 33070610003 | ||||||
| PHILLIPS, Adrian Roy | Secrétaire | Russet Manor 3 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Buckinghamshire | British | 47609330001 | ||||||
| AIRD, Robert Service | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 33070610001 | ||||||
| ARCHER, David Birdwood | Administrateur | Bridge Street RG1 2LU Reading 4th Floor, The Anchorage England | United Kingdom | British | 100574120017 | |||||
| AVERY, Christopher Henry | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | England | British | 63990350002 | |||||
| BRITTON, Sally | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | England | British | 165880780001 | |||||
| BROOKER, Suzanne Kay | Administrateur | Bridge Street RG1 2LU Reading 4th Floor, The Anchorage England | England | British | 70046700005 | |||||
| BUCKNELL, Neil John | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 39845440001 | ||||||
| BURGESS, James Christopher Appleyard | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 77285000002 | ||||||
| CARR, David John Hallett | Administrateur | 36 Bathwick Hill BA2 6LD Bath Avon | British | 66736740001 | ||||||
| CARRODUS, Stephen Charles | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | Uk | 17533860005 | |||||
| CATER, Sheila Ann Macdonald | Administrateur | 15 Oakthorpe Road OX2 7BD Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 73922770001 | |||||
| CHOUDRI, Ferhat Jehangeer | Administrateur | Bridge Street RG1 2LU Reading 4th Floor, The Anchorage England | United Kingdom | British | 89967970001 | |||||
| CLARK, Timothy George David | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | England | British | 115032150001 | |||||
| CLARKE, Helen | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 133468180002 | |||||
| COOLEY, Anthony Edward | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 4317940003 | ||||||
| CROWTHER, Susan Valerie | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 117199590001 | |||||
| DALLAS, Irene Ann | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 74755710003 | ||||||
| DANIELS, Christina | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 182826830001 | |||||
| DAVIES, Alan Alfred | Administrateur | Castle Street RG1 7SR Reading 47 Berkshire Uk | United Kingdom | British | 160913850001 | |||||
| DAVIES, Andrew George | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 141926510001 | |||||
| DAVY, Jeremy Michael | Administrateur | Bridge Street RG1 2LU Reading 4th Floor, The Anchorage England | England | British | 289352640001 | |||||
| DEVALL, Richard James | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 133180350001 | |||||
| DOWDNEY, Adam Francis Mark | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 269339390001 | |||||
| DRUKARZ, Daniel | Administrateur | 18 Cheyne Walk NW4 3QJ London | British | 35799800002 | ||||||
| FAWCETT, Denise Sharon | Administrateur | 66 Cheapside EC2V 6LR London 1 Crown Court | United Kingdom | English | 160920330001 | |||||
| FISHLEIGH, Andrew Paul | Administrateur | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | British | 43209810001 | ||||||
| FLOWERS, Ian Stephen | Administrateur | 48 Craigweil Avenue WD7 7EY Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 123510890001 | |||||
| FREWIN, Mark Raymond | Administrateur | Hay Green Farmhouse Hay Green Blackmore CM4 OQL Ingatestone Essex | British | 105402110001 | ||||||
| GREGORY, Roger William | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 59500110002 | |||||
| GWILLIM, David | Administrateur | 47 Castle Street Reading RG1 7SR Berks | United Kingdom | British | 141281040002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PITSEC LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadfield Law Uk Llp | 01 déc. 2018 | Bartholomew Close EC1A 7BL London One United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PITSEC LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 10 déc. 2016 | 01 déc. 2018 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0