WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02454379
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DE FACTO 174 LIMITED20 déc. 198920 déc. 1989

    Quels sont les derniers comptes de WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 oct. 2013

    État du capital au 10 oct. 2013

    • Capital: GBP 15,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    18 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    18 pagesAA

    legacy

    10 pages395

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    1 pages403b

    legacy

    9 pages395

    legacy

    6 pages395

    Qui sont les dirigeants de WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    AUTY, Kenneth Ian
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    British50948540001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secrétaire
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    PLIMLEY, Martin Wilfred
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    British58693940001
    BATTY, Malcolm Child
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    Administrateur
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    British30753710001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    BRIMBLECOMBE, David John
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    Administrateur
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    British51190580001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HARROWSMITH, John Anthony
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    British62531490001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HOPE, Mark Nicholas John
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    British48039200002
    JONES, Gordon Pearce, Sir
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    British2677770001
    KNIGHT, Ian Graham
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    British36849090002
    KNIGHT, Ian Graham
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    British36849090001
    LEAVESLEY, James David
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish22565050001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Administrateur
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Administrateur
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    NEWMAN, James Henry
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    Administrateur
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    British6036000006
    NEWTON, Trevor
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    British53363050001
    SMITHIES, James Marchant
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37603190001
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Administrateur
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    WILSON, Brian Joseph
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    British13236280002

    WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental security agreement
    Créé le 19 févr. 2009
    Livré le 25 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Units 17A and 17B of that property k/a follingsby park gateshead t/no TY367999 (part thereof). See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 25 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Tenth supplemental trust deed
    Créé le 24 déc. 2008
    Livré le 07 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    A security agreement
    Créé le 24 déc. 2008
    Livré le 07 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transactions
    • 07 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 19 sept. 2007
    Livré le 26 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transactions
    • 26 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Ninth supplemental trust deed
    Créé le 15 mars 2007
    Livré le 03 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property known as unit 1, follingsby park, follingsby avenue, follingsby park, gateshead t/no TY344000; property known as unit 2 follingsby park, follingsby avenue, gateshead t/no TY306533. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 03 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenturedated 27 may 1999
    Créé le 17 janv. 2002
    Livré le 02 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the obligors or any of them to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (I) f/hol lnd and buildings known as unit 6A follingsby park,follingsby ave,wardley; t/no ty 344006; (ii) f/hold land/blds known as units 1,1A and 14 follingsby par,follingsby ave,wardley; ty 344000; plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transactions
    • 02 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guaranteeand mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Créé le 12 janv. 2001
    Livré le 25 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (or any of them) and/or on any account whatsoever (terms as defined)
    Brèves mentions
    Freehold and leasehold and and buildings at york business park nether poppletontitle number(s) NYK72823 NYK72824 NYK87325 NYK67562 NYK59785 NYK85871 NYK70416 NYK176559 freehold land and buildings atfollingsby park gateshead title number TY306533 freehold land and buildings at follingsby lane gateshead title number(s)all its right title and interest in andto the leases,the insurances, the assigned documents,the receivables account and any monies and rental income. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself Andthe Beneficiaries
    Transactions
    • 25 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 08 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over f/h land and buildings on the north east side of millfield lane nether poppleton york title number NYK59785, land at ings lane millfield nether poppleton york title number NYK85871, land lying to the south of A1237, nether poppleton york title number NYK70416, land lying to the north east of millfield lane nether poppleton york title number NYK176559, land at poppleton ings york title number NYK72823, land at skelton junction millfield lane nether poppleton york title number NYK72824, l/h land at skelton junction millfield lane york title number NYK87325 land on the south east of ings lane millfield nether poppleton york title number NYK67562 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 08 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the freehold land lying to the north side of follingsby lane wardley gateshead title number TY306533 and the freehold land lying to the north of follingsby lane pelaw gateshead title number TY243775 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 08 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1996
    Livré le 14 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H land comprising 11.4 acres or thereabouts and situate at nether poppleton north yorkshire t/no:- NYK17615 and fixed and floating charge over all assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transactions
    • 14 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 1996
    Livré le 15 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (excepting the existing subordinated loan of £615,000 advanced on 1ST february 1993)
    Brèves mentions
    Land/blds lying to the north of follingsby lane,pelaw gateshead in the county of tyne and wear; t/no ty 243775.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transactions
    • 15 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 déc. 1995
    Livré le 15 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the legal charge
    Brèves mentions
    1. freehold land at poppleton ings york title number nyk 72823 2. freehold land lying to the south of A1237 nether poppleton york title number nyk 70416. 3. freehold land at skelton junction millfield lane nether poppleton york and those other properties detailed on the form M395 and a fixed and floating charge over all the assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 1995
    Livré le 10 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (but excepting the existing subordinated loan advanced on 1ST february 1993)
    Brèves mentions
    78 acres 770 square yards approx situate at follingsby county of tyne and wear with a fixed and floating charge over all the assets.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises at thorp arch leeds west yorkshire a fixed and flaoting charge over all the assets present and future of the borrower for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H and f/h properties on the north side of varley st leeds west yorkshire t/nos WYK486001 WYK486002 and wyk 486004 a fixed and floating charge over all the assets of the borrower present and future for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at owlcotes hill stanningley leeds west yorkshire t/n wyk 464352A fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a leigh house varley st stanningley leeds west yorkshire for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises k/a apex quarry butcher hill horsforth west yorkshire t/n wyk 345268 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises on the s/w side of commercial rd kirkstall leeds west yorkshire t/n wyk 60216 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises k/a citygate wellington st leeds west yorkshire t/n wyk 219237 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises LTD
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 03 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises k/a priestly mills swinnow green pudsey west yorkshire t/n YWE58726 fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises Limited
    Transactions
    • 03 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental mortgage
    Créé le 10 janv. 1992
    Livré le 13 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The benefit of an agreement dated 2ND december 1991 between (1) white rose development enterprises limited and (2) safeway PLC. Relating to land at chow dene bank team valley gateshead (formerly k/a coal house) all proceeds of sale and all monies received under the agreement described.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises Limited.
    Transactions
    • 13 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 sept. 1991
    Livré le 01 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Benefit of an agreement for lease dated 30/3/90 benefit of an agreement dated 27/12/90 and proceeds of sale.
    Personnes ayant droit
    • Yw Enterprises Limited
    Transactions
    • 01 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0