LSUK 2009 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLSUK 2009 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02456232
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LSUK 2009 LIMITED ?

    • (5156) /
    • (5190) /

    Où se situe LSUK 2009 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LSUK 2009 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LITHO SUPPLIES (UK) LIMITED19 oct. 199319 oct. 1993
    LITHO SUPPLIES LIMITED05 févr. 199105 févr. 1991
    DRG LITHO SUPPLIES LIMITED26 janv. 199026 janv. 1990
    TESTRICH LIMITED29 déc. 198929 déc. 1989

    Quels sont les derniers comptes de LSUK 2009 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour LSUK 2009 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 août 2011

    19 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    24 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 juin 2010

    24 pages2.24B

    Changement d'adresse du siège social de 43-45 Portman Square London W1H 6LY le 28 juin 2010

    2 pagesAD01

    Résultat de la réunion des créanciers

    3 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    81 pages2.17B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    81 pages2.17B

    Cessation de la nomination de Simon Wellings en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Simon Wellings en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Williams en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de Litho Supplies Longmoor Lane Breaston Derby Derbyshire DE72 3BQ Uk le 13 janv. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.12B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Facility agreement 03/12/2009
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    14 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    38 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de LSUK 2009 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAMMOND, Michael John
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    Administrateur
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    EnglandBritish49566080001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Secrétaire
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    British48246470002
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Secrétaire
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    British76667130001
    BYFORD, John Peter
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    British17458340001
    COOPER, Terence Francis Charles
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    Administrateur
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    EnglandBritish102793570001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    Administrateur
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    EnglandBritish48246470002
    MULVANEY, Gerald Owen
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    Administrateur
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    United KingdomBritish36169070001
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    Administrateur
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    STOCKTON, James Wardlaw
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    British1381020001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish76667130001
    WILLIAMS, Edward Gordon
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish100565740001

    LSUK 2009 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 07 déc. 2009
    Livré le 17 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Db Invoice Finance 12 Limited
    Transactions
    • 17 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    All asset debenture
    Créé le 30 avr. 2009
    Livré le 12 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 12 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee and collateral debenture
    Créé le 14 janv. 1991
    Livré le 24 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from h s holdings limited to the chargee under the terms of the mezzanine loan agreement dated 14/1/91.
    Brèves mentions
    All property as described in schedule, the goodwill and uncalled capital bookdebts, see form 395 (ref 436) and schedule for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group Plcers as Definedfor Itself and as Agent and Trustee for the Lend
    Transactions
    • 24 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 1991
    Livré le 17 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 4 avon trading estate albert road st philips bristol avon T.no av 168492.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 1991
    Livré le 17 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and premises at dale street bilston wolverhampton west midlands t/no sf 103559, wm 164694 and sf 112396.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset
    Créé le 14 janv. 1991
    Livré le 17 janv. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or l s holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Any sums now or hereafter standing to the credit of any account or accounts in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 14 janv. 1991
    Livré le 17 janv. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 1997Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    LSUK 2009 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 déc. 2009Administration started
    26 août 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    DateType
    26 août 2010Commencement of winding up
    22 août 2012Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    practitioner
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0