REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED

REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02456356
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Hall Barn Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    Oxfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORTH WEST ESTATES (WHITCHURCH) LIMITED19 nov. 199219 nov. 1992
    NORTH WEST ESTATES (HATHERN) LIMITED26 févr. 199026 févr. 1990
    GRANDMILE LIMITED29 déc. 198929 déc. 1989

    Quels sont les derniers comptes de REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 nov. 2013

    État du capital au 13 nov. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    11 pagesAA

    Nomination de Miss Carly Colman en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Ashken en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2011 au 31 déc. 2011

    1 pagesAA01

    legacy

    4 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * Number One Hillingdon Road Uxbridge Middlesex UB10 0AA* le 13 nov. 2009

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    13 pagesAA

    Divers

    Section 394
    1 pagesMISC

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    1 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    3 pages395

    Qui sont les dirigeants de REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLMAN, Carly
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    169548470001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish10187380006
    FINCKEN, Paul Edward
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    Administrateur
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    United KingdomBritish109887450001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    British10187380006
    FLICK SMITH, Sarah Louise
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    Secrétaire
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    British85593040001
    MANGAR, Sahadeo
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    Secrétaire
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    British48304010001
    PEARL, Brian Irving
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    British36426610001
    PEARL, Brian Irving
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    British36426610002
    POWER, Anthony John
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    British64225190001
    TURNER, Martin Neely
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    Secrétaire
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    British2308620001
    WILKINS, Christopher Nicholas
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    Secrétaire
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    British37360310001
    HALLAM FINANCIAL PLANNING SERVICES LTD
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    Secrétaire
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    42486160001
    CARTER, Anthony David
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    British35406890001
    FINCKEN, Kenneth John
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    Administrateur
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    United KingdomBritish41926340010
    MCMILLAN, Robin Chichester
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    Administrateur
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    British35995090001

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fifty (50) shares of £1 each in highland trilatera limited together with all allotments, accretions, benefits and advantages whatever now or in the future accruing in respect of them. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bradda Finance and Investment Limited
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bradda Finance and Investment Limited
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 27 mai 2005
    Livré le 02 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from cheetham village investments L.P (debtor) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of security its interest pursuant to the joint venture agreement and amendments and variations thereto; will pay and discharge the secured liabilities in accordance with the terms of the facility letter. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 02 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 27 sept. 2000
    Livré le 29 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or northwest estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land on south west side of newcut west,ipswich,suffolk; t/no sk 39424.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 31 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 21 oct. 1991
    Livré le 31 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc M268C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 26 juin 1990
    Livré le 10 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0