PROFESSIONAL STAFF LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROFESSIONAL STAFF LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02459997
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Adresse du siège social
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAB STAFF LIMITED13 mars 199013 mars 1990
    APTFEED LIMITED16 janv. 199016 janv. 1990

    Quels sont les derniers comptes de PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Darren Mee en tant qu'administrateur le 20 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2015

    État du capital au 28 janv. 2015

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Cessation de la nomination de Andrew Jeremy Burchall en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Julia Robertson le 30 juin 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Julia Robertson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2014

    État du capital au 27 janv. 2014

    • Capital: GBP .02
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 déc. 2012

    14 pagesAA

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    15 pagesMG01

    legacy

    15 pagesMG01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 12 juil. 2012

    • Capital: GBP 0.02
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account and capital redemption reserve reduced 03/07/2012
    RES13

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2011

    13 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Pellipar House 1St Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de PROFESSIONAL STAFF LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    MEE, Darren
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish197107770001
    ROBERTSON, Julia
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    800
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish177421710002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    BLACKDEN, Benjamin Paul
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British12656880001
    CAMERON-CHILESHE, Stephanie Delores
    24 Fairway Avenue
    UB7 7AN West Drayton
    Middlesex
    Secrétaire
    24 Fairway Avenue
    UB7 7AN West Drayton
    Middlesex
    British96226170001
    LASHER, Cathy
    21 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    Secrétaire
    21 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    Usa57075870001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    SLADE, Richard
    31 Upcroft
    SL4 3NH Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    31 Upcroft
    SL4 3NH Windsor
    Berkshire
    British82272600001
    THORPE, Adele Loraine
    Wilton Cottage
    Puers Lane Jordans
    HP9 2TE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Wilton Cottage
    Puers Lane Jordans
    HP9 2TE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British59134290002
    WALKER, Michelle
    310 Stoke Poges Lane
    SL1 3LL Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    310 Stoke Poges Lane
    SL1 3LL Slough
    Berkshire
    British40223630002
    WORRALL, Kevin
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    British46493430003
    BALDWIN, Frederick William
    5 Capesthorne
    BH23 4AT Christchurch
    Dorset
    Administrateur
    5 Capesthorne
    BH23 4AT Christchurch
    Dorset
    British3513860001
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    Carisbrooke Manor
    Colwood Lane
    RH17 5QQ Bolney
    West Sussex
    Administrateur
    Carisbrooke Manor
    Colwood Lane
    RH17 5QQ Bolney
    West Sussex
    UkBritish34371910003
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    American34371910001
    BLACKDEN, Benjamin Paul
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Layters Way
    SL9 7QZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish12656880001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Administrateur
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritish72452740004
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    Administrateur
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    British15685720001
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish58806030001
    CULVER, Bruce Robert
    6592 East Oak Springs Drive
    Agoura
    FOREIGN California 91301
    Usa
    Administrateur
    6592 East Oak Springs Drive
    Agoura
    FOREIGN California 91301
    Usa
    American24306250002
    DIXEY, Andrew Roger
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    Administrateur
    Hill House
    Bloxham
    OX15 4PH Oxon
    EnglandBritish152068670001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Administrateur
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    HARRIS, Stewart Anthony
    Tadburn House
    2d Southampton Road
    SO51 8AF Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Tadburn House
    2d Southampton Road
    SO51 8AF Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish87055470001
    MACKINNON, Iain Francis
    Dolphin Cottage
    Church Road
    PO31 8HA Cowes
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Dolphin Cottage
    Church Road
    PO31 8HA Cowes
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish36453430002
    MAYNARD, John Charles, Dr
    Cyterswood
    South Park
    SL9 Gerrards Cross
    Bucks
    Administrateur
    Cyterswood
    South Park
    SL9 Gerrards Cross
    Bucks
    British30509740001
    MOULDING, Patricia Helen, Dr
    Vera Cottage Graham Road
    Cookham
    SL6 9JQ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Vera Cottage Graham Road
    Cookham
    SL6 9JQ Maidenhead
    Berkshire
    British62410730001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish38346120001
    REYNOLDS JR, Russell Seaman
    39 Clapboard Ride Road
    Greenwich
    Conneticut 06830
    Usa
    Administrateur
    39 Clapboard Ride Road
    Greenwich
    Conneticut 06830
    Usa
    American71368200002
    REYNOLDS JR, Russell Seaman
    39 Clapboard Ride Road
    Greenwich
    Conneticut 06830
    Usa
    Administrateur
    39 Clapboard Ride Road
    Greenwich
    Conneticut 06830
    Usa
    American71368200002
    UNGER, Roderic John
    1 Broom Hill
    Oaklands
    AL6 0SF Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Broom Hill
    Oaklands
    AL6 0SF Welwyn
    Hertfordshire
    British3940690001
    UNTERBERG, Thomas I
    49 East Sixty Seventh Street
    New York
    New York 10018
    Usa
    Administrateur
    49 East Sixty Seventh Street
    New York
    New York 10018
    Usa
    Us76230850001
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Administrateur
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001
    WORRALL, Kevin
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Guildersfield East Hill Farm Road
    Taplow
    SL6 0HQ Maidenhead
    Berkshire
    British46493430003

    PROFESSIONAL STAFF LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 23 août 2012
    Livré le 28 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Créé le 08 août 2012
    Livré le 14 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 06 mai 2008
    Livré le 23 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 23 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 mai 2008
    Livré le 17 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 24 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 juil. 2003
    Livré le 24 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC as Trustee for Itself and Gmac Commercial Finance Llc
    Transactions
    • 24 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 24 janv. 2001
    Livré le 30 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 janv. 2001
    Livré le 12 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Plot c, k/a langley business park station road langley slough t/no BK253152.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 janv. 2000
    Livré le 16 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC gts bid deposit bid number 83124100. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 29 janv. 1999
    Livré le 11 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Treasury deposit number 63379299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 mars 1996
    Livré le 11 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £555,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under a contract of even date
    Brèves mentions
    F/H buckland house, waterside drive, langley business park, slough berkshire t/no: BK253152.
    Personnes ayant droit
    • Buckland Limited
    Transactions
    • 11 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 1993
    Livré le 19 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 1991
    Livré le 18 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts and Co
    Transactions
    • 18 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0