MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02460488 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?
| Adresse du siège social | KPMG LLP 15 Canada Square Canary Wharf E14 5GL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 4 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 12 avr. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1-3 Strand London WC2N 5EH à 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB le 06 janv. 2015 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Megan Barnes en tant que secrétaire le 01 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 21 juil. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Consolidation des actions au 07 juil. 2014 | 5 pages | SH02 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2014
| 4 pages | SH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Forward en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Forward en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Clive Burns en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Heather Maria Rayner en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Flawn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Megan Barnes en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amy Bailey en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNS, Clive | Administrateur | Canada Square Canary Wharf E14 5GL London 15 | United Kingdom | British | 173479520001 | |||||
| RAYNER, Heather Maria | Administrateur | Canada Square Canary Wharf E14 5GL London 15 | United Kingdom | English | 84501530001 | |||||
| ALLEN, Tracy | Secrétaire | 16 Castle Road TW7 6QS Isleworth Middlesex | British | 52970100001 | ||||||
| BAILEY, Amy Lynda | Secrétaire | 1-3 Strand London WC2N 5EH | 157503880002 | |||||||
| BAKER, Helen Alice | Secrétaire | 28 Silverstone Close RH1 2HQ Redhill Surrey | British | 108742050002 | ||||||
| BARNES, Megan | Secrétaire | 1-3 Strand London WC2N 5EH | 253071560001 | |||||||
| COCKBURN, Emma Suzanne | Secrétaire | Redhill Cottage Redhill, Wateringbury ME18 5LA Maidstone Kent | British | 125280550001 | ||||||
| DURRANT, Andrew Peter | Secrétaire | 340 Sidegate Lane IP4 3DW Ipswich Suffolk | British | 85381310004 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Secrétaire | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| FORWARD, David Charles | Secrétaire | 1-3 Strand London WC2N 5EH | British | 26385930010 | ||||||
| GRIFFIN, John Edward Henry | Secrétaire | 155 Cannon Lane HA5 1HU Pinner Middlesex | British | 4516200001 | ||||||
| HIGGINS, Philip Lyndon | Secrétaire | Strand WC2N 5EH London 1-3 United Kingdom | 150538540001 | |||||||
| MACAULAY, Barbara Scott | Secrétaire | 1 Mayfield Close AL5 3LG Harpenden Hertfordshire | British | 39335990001 | ||||||
| MARKHAM, Una | Secrétaire | 18 Howard Road RG40 2BX Wokingham Berkshire | British | 49024710001 | ||||||
| PERKINS, Helen Margaret | Secrétaire | 62 Chestnut Road Raynes Park SW20 8EB London | British | 35079080001 | ||||||
| POOLE, Andrew Philip | Secrétaire | Flat 28 2 Lansdowne Drive E8 3EZ London | British | 90354630001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Secrétaire | 32 Tewkesbury Avenue HA5 5LH Pinner Middlesex | British | 1780560001 | ||||||
| SOUTH, Victoria Anne | Secrétaire | Voltaire 330 Garratt Lane SW18 4FQ London Flat 18 United Kingdom | British | 133751600001 | ||||||
| ASH, Paul | Administrateur | Beethovenlaan 10 1Z17CJ Hilversum Netherlandsa | British | 53170010001 | ||||||
| BAKER, Helen Alice | Administrateur | 28 Silverstone Close RH1 2HQ Redhill Surrey | British | 108742050002 | ||||||
| COOPER, Scott | Administrateur | 41 Greenwich South Street Greenwich SG10 8NT London | British | 64610590001 | ||||||
| DURRANT, Andrew Peter | Administrateur | 340 Sidegate Lane IP4 3DW Ipswich Suffolk | British | 85381310004 | ||||||
| ELLIS, Ralph Lewis | Administrateur | Nettlebeds SO24 9RF Old Alresford Hampshire | Great Britain | British | 45186780001 | |||||
| EVANS, David Kelvin | Administrateur | 5 Templeton Close Dorridge B93 8LS Solihull West Midlands | British | 33559770001 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Administrateur | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| FITZGERALD, David | Administrateur | Manor Hill Lordsley Ashley TF9 4EQ Market Drayton Salop | British | 14419000002 | ||||||
| FLAWN, Mark Antony David | Administrateur | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | 77245330002 | |||||
| FORWARD, David Charles | Administrateur | 1-3 Strand London WC2N 5EH | United Kingdom | British | 26385930010 | |||||
| JONES, Gareth David Batten | Administrateur | 18b Queen Annes Grove Chiswick W4 1HN London | British | 47894190001 | ||||||
| JONES, Michael Edward | Administrateur | 3 Maythorn Grove B91 3JS Solihull West Midlands | England | British | 4483730001 | |||||
| KIRBY, Phillip Charles | Administrateur | White House Cottage Winchester Road Wherwell SP11 7HW Andover | England | British | 48127680001 | |||||
| MCKENDRY, Brian John | Administrateur | Orchard House Mile Path GU22 0JX Woking Surrey | England | British | 49477230001 | |||||
| NOBLE, Mark David | Administrateur | 29 Avondale Road Mortlake SW14 8PU London | Uk | British | 125124050001 | |||||
| PARKINSON, David Lister | Administrateur | 3 Radley Mews W8 6JP London | British | 62703050001 | ||||||
| PATIENCE, Donald William John | Administrateur | 6 Horton Close BA15 1UG Bradford-On-Avon Wiltshire | British | 33559800001 |
MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 20 juin 1991 Livré le 11 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that freehold property forming part of land and buildings on the south side of devon street nechells birmingham west midlands all which property forms part of land registry title number wm 505118. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 20 juin 1991 Livré le 05 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All existing and future freehold and leasehold property of the company together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 20 juin 1991 Livré le 20 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,686,573 due from the co. To the chargee under the terms of a joint venture agreement dated 27/4/90 as varied by a deed of agreement dated 20/6/91. | |
Brèves mentions Land at devon street saltley having an area of approx 13.43 acres t/n wm 505118 together with any part of the development thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0