MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED

MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02460488
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INGLEBY (461) LIMITED17 janv. 199017 janv. 1990

    Quels sont les derniers comptes de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 12 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 1-3 Strand London WC2N 5EH à 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB le 06 janv. 2015

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 déc. 2014

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Cessation de la nomination de Megan Barnes en tant que secrétaire le 01 déc. 2014

    1 pagesTM02

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Consolidation des actions au 07 juil. 2014

    5 pagesSH02

    État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,249,001
    4 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital après une attribution d'actions au 15 janv. 2014

    SH01

    Cessation de la nomination de David Forward en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Forward en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Clive Burns en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Heather Maria Rayner en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Flawn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    5 pagesAA

    Nomination de Megan Barnes en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Amy Bailey en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNS, Clive
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish173479520001
    RAYNER, Heather Maria
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomEnglish84501530001
    ALLEN, Tracy
    16 Castle Road
    TW7 6QS Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire
    16 Castle Road
    TW7 6QS Isleworth
    Middlesex
    British52970100001
    BAILEY, Amy Lynda
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Secrétaire
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    157503880002
    BAKER, Helen Alice
    28 Silverstone Close
    RH1 2HQ Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    28 Silverstone Close
    RH1 2HQ Redhill
    Surrey
    British108742050002
    BARNES, Megan
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Secrétaire
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    253071560001
    COCKBURN, Emma Suzanne
    Redhill Cottage
    Redhill, Wateringbury
    ME18 5LA Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Redhill Cottage
    Redhill, Wateringbury
    ME18 5LA Maidstone
    Kent
    British125280550001
    DURRANT, Andrew Peter
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    British85381310004
    EVES, Richard Anthony
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    British51097960001
    FORWARD, David Charles
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Secrétaire
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    British26385930010
    GRIFFIN, John Edward Henry
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    155 Cannon Lane
    HA5 1HU Pinner
    Middlesex
    British4516200001
    HIGGINS, Philip Lyndon
    Strand
    WC2N 5EH London
    1-3
    United Kingdom
    Secrétaire
    Strand
    WC2N 5EH London
    1-3
    United Kingdom
    150538540001
    MACAULAY, Barbara Scott
    1 Mayfield Close
    AL5 3LG Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Mayfield Close
    AL5 3LG Harpenden
    Hertfordshire
    British39335990001
    MARKHAM, Una
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    18 Howard Road
    RG40 2BX Wokingham
    Berkshire
    British49024710001
    PERKINS, Helen Margaret
    62 Chestnut Road
    Raynes Park
    SW20 8EB London
    Secrétaire
    62 Chestnut Road
    Raynes Park
    SW20 8EB London
    British35079080001
    POOLE, Andrew Philip
    Flat 28 2 Lansdowne Drive
    E8 3EZ London
    Secrétaire
    Flat 28 2 Lansdowne Drive
    E8 3EZ London
    British90354630001
    SADLER, John Michael
    32 Tewkesbury Avenue
    HA5 5LH Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    32 Tewkesbury Avenue
    HA5 5LH Pinner
    Middlesex
    British1780560001
    SOUTH, Victoria Anne
    Voltaire
    330 Garratt Lane
    SW18 4FQ London
    Flat 18
    United Kingdom
    Secrétaire
    Voltaire
    330 Garratt Lane
    SW18 4FQ London
    Flat 18
    United Kingdom
    British133751600001
    ASH, Paul
    Beethovenlaan 10
    1Z17CJ Hilversum
    Netherlandsa
    Administrateur
    Beethovenlaan 10
    1Z17CJ Hilversum
    Netherlandsa
    British53170010001
    BAKER, Helen Alice
    28 Silverstone Close
    RH1 2HQ Redhill
    Surrey
    Administrateur
    28 Silverstone Close
    RH1 2HQ Redhill
    Surrey
    British108742050002
    COOPER, Scott
    41 Greenwich South Street
    Greenwich
    SG10 8NT London
    Administrateur
    41 Greenwich South Street
    Greenwich
    SG10 8NT London
    British64610590001
    DURRANT, Andrew Peter
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    340 Sidegate Lane
    IP4 3DW Ipswich
    Suffolk
    British85381310004
    ELLIS, Ralph Lewis
    Nettlebeds
    SO24 9RF Old Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    Nettlebeds
    SO24 9RF Old Alresford
    Hampshire
    Great BritainBritish45186780001
    EVANS, David Kelvin
    5 Templeton Close
    Dorridge
    B93 8LS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    5 Templeton Close
    Dorridge
    B93 8LS Solihull
    West Midlands
    British33559770001
    EVES, Richard Anthony
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    British51097960001
    FITZGERALD, David
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    Manor Hill Lordsley
    Ashley
    TF9 4EQ Market Drayton
    Salop
    British14419000002
    FLAWN, Mark Antony David
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Administrateur
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    United KingdomBritish77245330002
    FORWARD, David Charles
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    Administrateur
    1-3 Strand
    London
    WC2N 5EH
    United KingdomBritish26385930010
    JONES, Gareth David Batten
    18b Queen Annes Grove
    Chiswick
    W4 1HN London
    Administrateur
    18b Queen Annes Grove
    Chiswick
    W4 1HN London
    British47894190001
    JONES, Michael Edward
    3 Maythorn Grove
    B91 3JS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    3 Maythorn Grove
    B91 3JS Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish4483730001
    KIRBY, Phillip Charles
    White House Cottage
    Winchester Road Wherwell
    SP11 7HW Andover
    Administrateur
    White House Cottage
    Winchester Road Wherwell
    SP11 7HW Andover
    EnglandBritish48127680001
    MCKENDRY, Brian John
    Orchard House
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    Mile Path
    GU22 0JX Woking
    Surrey
    EnglandBritish49477230001
    NOBLE, Mark David
    29 Avondale Road
    Mortlake
    SW14 8PU London
    Administrateur
    29 Avondale Road
    Mortlake
    SW14 8PU London
    UkBritish125124050001
    PARKINSON, David Lister
    3 Radley Mews
    W8 6JP London
    Administrateur
    3 Radley Mews
    W8 6JP London
    British62703050001
    PATIENCE, Donald William John
    6 Horton Close
    BA15 1UG Bradford-On-Avon
    Wiltshire
    Administrateur
    6 Horton Close
    BA15 1UG Bradford-On-Avon
    Wiltshire
    British33559800001

    MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 20 juin 1991
    Livré le 11 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that freehold property forming part of land and buildings on the south side of devon street nechells birmingham west midlands all which property forms part of land registry title number wm 505118.
    Personnes ayant droit
    • The National Mortgage Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 20 juin 1991
    Livré le 05 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All existing and future freehold and leasehold property of the company together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The National Mortgage Bank P.L.C.
    Transactions
    • 05 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 juin 1991
    Livré le 20 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,686,573 due from the co. To the chargee under the terms of a joint venture agreement dated 27/4/90 as varied by a deed of agreement dated 20/6/91.
    Brèves mentions
    Land at devon street saltley having an area of approx 13.43 acres t/n wm 505118 together with any part of the development thereon.
    Personnes ayant droit
    • British Gas PLC.
    Transactions
    • 20 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MAINSTREAM FORTY-SEVEN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 mars 2016Dissolved on
    09 déc. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0