ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02463879 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 250 Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Timothy Walter Gregory le 24 juil. 2013 | 3 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 sept. 2012 | 3 pages | AA01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr. Timothy Walter Gregory en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr. Robert David Anderson en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr. Faris Mehdi Kadhim Mohammed en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Peter Griggs en tant que directeur le 19 sept. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alice Rivers en tant que directeur le 19 sept. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 3 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Logica Cosec Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2011 | 3 pages | AP04 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Logica International Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2011 | 2 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 11 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 3 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Mackay en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Gavin Peter Griggs en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Logica International Limited le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGICA COSEC LIMITED | Secrétaire | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 United Kingdom |
| 165434150001 | ||||||||||
| ANDERSON, Robert David, Mr. | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | Canada | Canadian | 122988350004 | |||||||||
| GREGORY, Timothy Walter | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | England | British | 149429760002 | |||||||||
| MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | England | British | 67645590001 | |||||||||
| BLACKMAN, Kenneth | Secrétaire | 3 Selwood Terrace SW7 3QN London | British | 42539880001 | ||||||||||
| FRANCIS, Richard John | Secrétaire | 7 Kinderscout HP3 8HW Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 67742720001 | ||||||||||
| PATON, Daryl Marc | Secrétaire | Miles Lane KT11 2EF Cobham Easter House Surrey | British | 104564540001 | ||||||||||
| LOGICA INTERNATIONAL LIMITED | Secrétaire | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 |
| 45193120003 | ||||||||||
| AUER, Adrian Richard | Administrateur | Rme House Coldharbour Lane TW20 8TD Thorpe Egham Surrey | United Kingdom | British | 105271660001 | |||||||||
| BLACKMAN, Kenneth | Administrateur | 3 Selwood Terrace SW7 3QN London | British | 42539880001 | ||||||||||
| BRADSHAW, Michael | Administrateur | 46 Scatterdells Lane Chipperfield WD4 9ET Kings Langley Hertfordshire | British | 57941410001 | ||||||||||
| BRENDISH, Clayton Mark | Administrateur | Horseshoe House Coworth Park, London Road Sunninghill SL5 7SE Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 11857380004 | |||||||||
| CRAIG, Peter John | Administrateur | 9 Clayfield Yate BS17 5PE Bristol Avon | British | 28293230002 | ||||||||||
| FLOYDD, William | Administrateur | 27 Dagden Road GU4 8DD Shalford Surrey | British | 101702410001 | ||||||||||
| GRIGGS, Gavin Peter | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | England | British | 154536120001 | |||||||||
| HAMMILL, George | Administrateur | 6 Abbotsbury Road Bishopstoke SO50 8NZ Eastleigh Hampshire | British | 76504500001 | ||||||||||
| HAMMILL, George | Administrateur | 6 Abbotsbury Road Bishopstoke SO50 8NZ Eastleigh Hampshire | British | 76504500001 | ||||||||||
| HARRISON, Simon Charles | Administrateur | Laurel House Goose Lane GU22 0NW Woking Surrey | England | British | 120581670001 | |||||||||
| JAMES, Ceri Lloyd | Administrateur | Fairacre 35 Compton Way GU10 1QT Farnham Surrey | British | 65996360001 | ||||||||||
| JONES, David Rodney | Administrateur | White Cottage Rectory Road, Oakley RG23 7ED Basingstoke Hampshire | British | 69172140001 | ||||||||||
| MACKAY, Thomas Owen | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | United Kingdom | British | 125924240001 | |||||||||
| MARSHALL, Jeffrey | Administrateur | 22 Riversdell Close KT16 9JW Chertsey Surrey | British | 37185850001 | ||||||||||
| MARSHALL, Jeffrey | Administrateur | 22 Riversdell Close KT16 9JW Chertsey Surrey | British | 37185850001 | ||||||||||
| MELLORS, David Antony | Administrateur | Cody Technology Park Ively Road GU14 0LX Farnborough A1/2009 Hampshire Uk | England | British | 166957670001 | |||||||||
| MUNRO, Alan Malcolm | Administrateur | Holly Bank Lodge 150a Nine Mile Ride RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | 55767650001 | ||||||||||
| NEVILLE, Geoffrey Leslie | Administrateur | 53 Church Road Abbots Leigh BS8 3QU Bristol Avon | United Kingdom | British | 39989270002 | |||||||||
| NEVILLE, Geoffrey Leslie | Administrateur | 53 Church Road Abbots Leigh BS8 3QU Bristol Avon | United Kingdom | British | 39989270002 | |||||||||
| PARKER, Anthony Hugh | Administrateur | 4 Baldock Road SG6 3LB Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 90058690001 | |||||||||
| RIVERS, Alice | Administrateur | Brook Drive Green Park RG2 6UA Reading 250 | England | British | 135315640001 | |||||||||
| SMITH, Adrian Trevor | Administrateur | 36 The Willows Highworth SN6 7PG Swindon Wiltshire | United Kingdom | British | 44525580002 | |||||||||
| WEAVER, Paul | Administrateur | Brookside CM11 1DT Billericay 36 Essex | United Kingdom | British | 45193280002 |
ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Letter of charge | Créé le 14 juil. 1995 Livré le 04 août 1995 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit agreement | Créé le 26 nov. 1993 Livré le 03 déc. 1993 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 26TH november 1993 | |
Brèves mentions £4,876.25 due or to become due from the company to the chargee. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 11 nov. 1991 Livré le 19 nov. 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit agreement | Créé le 15 mai 1991 Livré le 16 mai 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of 2 leases dated 15.5.91 | |
Brèves mentions £4.150.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0