ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED

ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02463879
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    250 Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE TRAINING CENTRE LIMITED26 janv. 199026 janv. 1990

    Quels sont les derniers comptes de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2013

    État du capital au 06 août 2013

    • Capital: GBP 52,750
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Timothy Walter Gregory le 24 juil. 2013

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    3 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 sept. 2012

    3 pagesAA01

    Nomination de Mr. Timothy Walter Gregory en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Robert David Anderson en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr. Faris Mehdi Kadhim Mohammed en tant qu'administrateur le 19 sept. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gavin Peter Griggs en tant que directeur le 19 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alice Rivers en tant que directeur le 19 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Logica Cosec Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2011

    3 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Logica International Limited en tant que secrétaire le 07 déc. 2011

    2 pagesTM02

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Authority in accordance with sec 175(5)(a) 22/09/2011
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Thomas Mackay en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Gavin Peter Griggs en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Logica International Limited le 01 oct. 2009

    2 pagesCH04

    Qui sont les dirigeants de ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOGICA COSEC LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Secrétaire
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7745327
    165434150001
    ANDERSON, Robert David, Mr.
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    CanadaCanadian122988350004
    GREGORY, Timothy Walter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish149429760002
    MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish67645590001
    BLACKMAN, Kenneth
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    Secrétaire
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    British42539880001
    FRANCIS, Richard John
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    7 Kinderscout
    HP3 8HW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British67742720001
    PATON, Daryl Marc
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    Secrétaire
    Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Easter House
    Surrey
    British104564540001
    LOGICA INTERNATIONAL LIMITED
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Secrétaire
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1237299
    45193120003
    AUER, Adrian Richard
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    Administrateur
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    United KingdomBritish105271660001
    BLACKMAN, Kenneth
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    Administrateur
    3 Selwood Terrace
    SW7 3QN London
    British42539880001
    BRADSHAW, Michael
    46 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9ET Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    46 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9ET Kings Langley
    Hertfordshire
    British57941410001
    BRENDISH, Clayton Mark
    Horseshoe House
    Coworth Park, London Road Sunninghill
    SL5 7SE Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Horseshoe House
    Coworth Park, London Road Sunninghill
    SL5 7SE Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish11857380004
    CRAIG, Peter John
    9 Clayfield
    Yate
    BS17 5PE Bristol
    Avon
    Administrateur
    9 Clayfield
    Yate
    BS17 5PE Bristol
    Avon
    British28293230002
    FLOYDD, William
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    Administrateur
    27 Dagden Road
    GU4 8DD Shalford
    Surrey
    British101702410001
    GRIGGS, Gavin Peter
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish154536120001
    HAMMILL, George
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British76504500001
    HAMMILL, George
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    6 Abbotsbury Road
    Bishopstoke
    SO50 8NZ Eastleigh
    Hampshire
    British76504500001
    HARRISON, Simon Charles
    Laurel House
    Goose Lane
    GU22 0NW Woking
    Surrey
    Administrateur
    Laurel House
    Goose Lane
    GU22 0NW Woking
    Surrey
    EnglandBritish120581670001
    JAMES, Ceri Lloyd
    Fairacre
    35 Compton Way
    GU10 1QT Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Fairacre
    35 Compton Way
    GU10 1QT Farnham
    Surrey
    British65996360001
    JONES, David Rodney
    White Cottage
    Rectory Road, Oakley
    RG23 7ED Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    White Cottage
    Rectory Road, Oakley
    RG23 7ED Basingstoke
    Hampshire
    British69172140001
    MACKAY, Thomas Owen
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    United KingdomBritish125924240001
    MARSHALL, Jeffrey
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    British37185850001
    MARSHALL, Jeffrey
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    22 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    British37185850001
    MELLORS, David Antony
    Cody Technology Park
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    A1/2009
    Hampshire
    Uk
    Administrateur
    Cody Technology Park
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    A1/2009
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritish166957670001
    MUNRO, Alan Malcolm
    Holly Bank Lodge 150a Nine Mile Ride
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Holly Bank Lodge 150a Nine Mile Ride
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British55767650001
    NEVILLE, Geoffrey Leslie
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    Administrateur
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    United KingdomBritish39989270002
    NEVILLE, Geoffrey Leslie
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    Administrateur
    53 Church Road
    Abbots Leigh
    BS8 3QU Bristol
    Avon
    United KingdomBritish39989270002
    PARKER, Anthony Hugh
    4 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Baldock Road
    SG6 3LB Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish90058690001
    RIVERS, Alice
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UA Reading
    250
    EnglandBritish135315640001
    SMITH, Adrian Trevor
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    36 The Willows
    Highworth
    SN6 7PG Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish44525580002
    WEAVER, Paul
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    Administrateur
    Brookside
    CM11 1DT Billericay
    36
    Essex
    United KingdomBritish45193280002

    ADMIRAL TRAINING CENTRES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 14 juil. 1995
    Livré le 04 août 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit agreement
    Créé le 26 nov. 1993
    Livré le 03 déc. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 26TH november 1993
    Brèves mentions
    £4,876.25 due or to become due from the company to the chargee.
    Personnes ayant droit
    • Broadwell Land PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 nov. 1991
    Livré le 19 nov. 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit agreement
    Créé le 15 mai 1991
    Livré le 16 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of 2 leases dated 15.5.91
    Brèves mentions
    £4.150.00.
    Personnes ayant droit
    • Broadwell Kind PLC
    Transactions
    • 16 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0