FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED

FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02464241
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RAPID 9592 LIMITED26 janv. 199026 janv. 1990

    Quels sont les derniers comptes de FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2011

    État du capital au 13 déc. 2011

    • Capital: GBP 2,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Richard John Amos le 21 nov. 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard John Amos le 21 nov. 2010

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Sadler en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Richard John Amos en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paresh Sejpar en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paresh Sejpar le 01 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Anthony Bass le 01 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mike Kingswood le 01 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Michael Sadler le 01 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Richard John Amos en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2009

    3 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AMOS, Richard John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Secrétaire
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British149450940001
    AMOS, Richard John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Administrateur
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish67950460002
    BASS, Neil Anthony
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Administrateur
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish70199330002
    KINGSWOOD, Mike
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Administrateur
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritish136212700001
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Secrétaire
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HAYES, David
    Turnhams Gill
    Furners Lane
    BN5 9HX Henfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Turnhams Gill
    Furners Lane
    BN5 9HX Henfield
    West Sussex
    British96727550001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secrétaire
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Secrétaire
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    JONES, Kevin John Francis
    13 Rumptons Paddock
    Grendon Underwood
    HP18 0SN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    13 Rumptons Paddock
    Grendon Underwood
    HP18 0SN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British38031690001
    SADLER, John Michael
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Secrétaire
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British78431540001
    TYLER, Michael
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    Secrétaire
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    British66927520001
    BAINS, Jagjit
    Hawkstone Jigs Lane South
    Warfield
    RG42 3DR Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Hawkstone Jigs Lane South
    Warfield
    RG42 3DR Bracknell
    Berkshire
    British60082710001
    CHAMPNESS, Ian Nicholas
    The Old Cottage
    Shalden Lane
    GU34 4DU Shaldon Alton
    Hampshire
    Administrateur
    The Old Cottage
    Shalden Lane
    GU34 4DU Shaldon Alton
    Hampshire
    EnglandBritish88498340001
    HAYES, David
    Turnhams Gill
    Furners Lane
    BN5 9HX Henfield
    West Sussex
    Administrateur
    Turnhams Gill
    Furners Lane
    BN5 9HX Henfield
    West Sussex
    United KingdomBritish96727550001
    HIPWELL, Leslie Charles
    12 Barn Owl Way
    RG7 3XX Burghfield Common
    Berkshire
    Administrateur
    12 Barn Owl Way
    RG7 3XX Burghfield Common
    Berkshire
    United KingdomBritish116139220001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Administrateur
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    JONES, Kevin John Francis
    13 Rumptons Paddock
    Grendon Underwood
    HP18 0SN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    13 Rumptons Paddock
    Grendon Underwood
    HP18 0SN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British38031690001
    MCDONALD, Margaret Irene
    13 Mayfield
    Worth
    RH10 7FT Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    13 Mayfield
    Worth
    RH10 7FT Crawley
    West Sussex
    British16553650001
    SEJPAR, Paresh
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Administrateur
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritish79716650001
    SOWTON, John Barry
    2 Hillcrest Cottages
    London Road Bolney
    RH17 5PY Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    2 Hillcrest Cottages
    London Road Bolney
    RH17 5PY Haywards Heath
    West Sussex
    British48630420001
    SPIERS, Edward Corbett
    Abbots Lodge
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Abbots Lodge
    Monks Walk
    SL5 9AZ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish141320370001
    TYLER, Michael
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    Administrateur
    8 Green Road
    CT7 9JZ Birchington
    Kent
    United KingdomBritish66927520001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    WRIGHT, Michael
    Oak Lodge
    1a Priory Lane
    RG42 2JU Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    Oak Lodge
    1a Priory Lane
    RG42 2JU Warfield
    Berkshire
    EnglandBritish74448860001

    FSS TRAVEL & LEISURE SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 juil. 1999
    Livré le 06 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Investments Limited; As Security Trustee for and on Behalf of the Investors (Asdefined) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 1999
    Livré le 03 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 22 oct. 1996
    Livré le 07 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 16 nov. 1993
    Livré le 30 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 30 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 nov. 1992
    Livré le 17 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 20 sept. 1991
    Livré le 30 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0