TAVERNER (1) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TAVERNER (1) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02466749 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TAVERNER (1) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Fibresec Holdings Ltd Snaygill Ind Estate BD23 2QR Keighley Road, Skipton North Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TAVERNER (1) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TAVERNER (1) LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour TAVERNER (1) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed foam technology LIMITED\certificate issued on 30/10/13 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 02 oct. 2013
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Paul Heath le 18 oct. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Peter Thompson le 15 mars 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Ann Jacqueline Preston le 15 mars 2012 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2010 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Peter Thompson le 04 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TAVERNER (1) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTON, Ann Jacqueline | Secrétaire | C/O Fibresec Holdings Ltd Snaygill Ind Estate BD23 2QR Keighley Road, Skipton North Yorkshire | British | 110426760001 | ||||||
| HEATH, Martin Paul | Administrateur | C/O Fibresec Holdings Ltd Snaygill Ind Estate BD23 2QR Keighley Road, Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | 20585800006 | |||||
| THOMPSON, Ian Peter | Administrateur | C/O Fibresec Holdings Ltd Snaygill Ind Estate BD23 2QR Keighley Road, Skipton North Yorkshire | England | British | 46127620002 | |||||
| JENNINGS, Michael | Secrétaire | Unit 2 Snaygill Industrial Estate Keighley Road Skipton North Yorkshire | British | 30584730001 | ||||||
| LEESING, Brian | Secrétaire | Limestones Back Lane Old Edlington DN12 1QA Doncaster South Yorkshire | British | 19080600002 | ||||||
| THOMPSON, Ian Peter | Secrétaire | Merrimead Constable Road LS29 8RW Ben Rhydding Ilkley West Yorkshire | British | 46127620002 | ||||||
| WATSON, Keith | Secrétaire | 18 Harrowby Road LS16 5HX Leeds West Yorkshire | British | 33828510001 | ||||||
| CROSSLAND, John Stuart | Administrateur | Park House Bankwell Giggleswick BD24 0AP Settle North Yorkshire | England | British | 83891300001 | |||||
| JENNINGS, Michael | Administrateur | Mickleden Ladder Banks Lane Baildon Shipley Bradford West Yorkshire | British | 1951910001 | ||||||
| KEMP, Steven | Administrateur | 11 Coppy Road Addingham LS29 Ilkley West Yorkshire | British | 39217900002 | ||||||
| LEESING, Brian | Administrateur | Limestones Back Lane Old Edlington DN12 1QA Doncaster South Yorkshire | England | British | 19080600002 | |||||
| PARDOE, Trevor William | Administrateur | Woodstock House Bleach Mill Lane Menston LS29 6AN Ilkley West Yorkshire | British | 3465590001 | ||||||
| TURNER, David Deacon | Administrateur | Swinnow Hill York Road LS22 5EL Wetherby West Yorkshire | British | 3465600001 | ||||||
| TURNER, John Deacon | Administrateur | 15 Bracken Park Scarcroft LS14 3HZ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 1140750002 |
TAVERNER (1) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture & guarantee | Créé le 11 sept. 1992 Livré le 29 sept. 1992 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the loanstock agreement(as defined) and this charge | |
Brèves mentions See form 395 ref M439C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 11 sept. 1992 Livré le 24 sept. 1992 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions For full details see form 395 tc ref: M346C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 janv. 1991 Livré le 06 févr. 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0