PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02467508
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP le 14 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 sept. 2012

    LRESSP

    Nomination de Mr Kenneth Mcintyre Carlaw en tant qu'administrateur le 28 août 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nigel Paul Featham en tant que directeur le 28 août 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Anthony Bowler en tant que directeur le 28 août 2012

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 26 mai 2012

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2011

    État du capital au 16 déc. 2011

    • Capital: GBP 220,002
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Nomination de Nigel Paul Featham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan May en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Elizabeth Anne Thorpe le 14 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Paul May le 14 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Anthony Bowler le 14 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Administrateur
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    CAMPBELL, David Gerard
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159840001
    JONES, Michael Adrian
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    British36134870001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    FICKLING, John Matthew
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British40818470001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    KENNAN, Anthony Denis
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159860001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Administrateur
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish125675730002
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British35862500001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Administrateur
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006

    PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattel mortgage
    Créé le 29 déc. 1994
    Livré le 29 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kentish bus & coach company limited and northumbria - motor services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the vehicles as described in the schedule to the form 395 including 17 x leyland olympian double decker buses and 2 x optare delta buses. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 29 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Créé le 15 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 11 août 1994
    Livré le 26 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transactions
    • 26 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 13 juil. 1990
    Livré le 23 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever (see form 395 for further details)
    Brèves mentions
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 23 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 1990
    Livré le 23 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for standard chartered bank and dresdner bank A.G. pursuant to a loan agreement of even date and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    (See form 395 for further details of specific property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee)
    Transactions
    • 23 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 avr. 2013Dissolved on
    04 sept. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    practitioner
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0