DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED

DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02467853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRIDGEMAN FIRTH AND ASSOCIATES LIMITED21 juil. 199221 juil. 1992
    ANDERMORE LIMITED07 févr. 199007 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 07 juin 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share [prem a/c to nil 02/06/2011
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    10 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    17 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    BEATTY, Adrian Paul
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    Irish1410620001
    BEATTY, Adrian Paul
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    Irish1410620001
    FIRTH, Jonathan
    The Old School
    High Street, Croydon
    SG8 0DN Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Old School
    High Street, Croydon
    SG8 0DN Royston
    Hertfordshire
    British55317790002
    FIRTH, Riochard Charles Jonathan
    Villa Caty Bajo 34
    Mujas Costa
    FOREIGN 29648 Malaga
    Spain
    Secrétaire
    Villa Caty Bajo 34
    Mujas Costa
    FOREIGN 29648 Malaga
    Spain
    British88970240001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    SMITH, Christopher Charles
    19 Moss Bank
    Chesterton
    CB4 1UR Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    19 Moss Bank
    Chesterton
    CB4 1UR Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Secretary29104710001
    WALKER, Murray
    Threeways 2 Denny End Road
    Waterbeach
    CB5 9PB Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Threeways 2 Denny End Road
    Waterbeach
    CB5 9PB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Secretary66876770001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    BEATTY, Adrian Paul
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Broad Leys
    Widdington
    CB11 3SP Saffron Walden
    Essex
    IrishDirector1410620001
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Blakemore House
    7 Oakley Manor Gardens Belle Vue
    SY3 7NT Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Blakemore House
    7 Oakley Manor Gardens Belle Vue
    SY3 7NT Shrewsbury
    Shropshire
    BritishIfa105488120002
    FIRTH, Jonathan
    The Old School
    High Street, Croydon
    SG8 0DN Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Old School
    High Street, Croydon
    SG8 0DN Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector55317790002
    FIRTH, Richard Charles Jonathon
    Villa Caty
    Los Claveles Bajo 34
    Mijas Costa
    Spain
    Administrateur
    Villa Caty
    Los Claveles Bajo 34
    Mijas Costa
    Spain
    BritishDirector/Financial Adviser28972060004
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishDirector98560430001
    MILLER, Andrew
    8 Eastby Close
    CB11 3BT Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    8 Eastby Close
    CB11 3BT Saffron Walden
    Essex
    BritishDirector1320460001
    NEVIN, Anthony James
    30a Byfield Road
    CB3 8UQ Papworth Everard
    Cambridge
    Administrateur
    30a Byfield Road
    CB3 8UQ Papworth Everard
    Cambridge
    BritishDirector51509700002
    NEVIN, Anthony James
    4 Mill Close
    Stotfold
    SG5 4AB Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Mill Close
    Stotfold
    SG5 4AB Hitchin
    Hertfordshire
    BritishFinancial Advisor51509700001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer130449650001
    SEWELL, Kenneth
    13 High Green
    Great Shelford
    CB2 5EG Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    13 High Green
    Great Shelford
    CB2 5EG Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director13419350001
    SMITH, Angus
    The Lane
    Creeting St Peter
    IP6 8QR Ipswich
    Bonnybridge House
    Suffolk
    Administrateur
    The Lane
    Creeting St Peter
    IP6 8QR Ipswich
    Bonnybridge House
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director130809170001
    WALKER, Murray
    Threeways 2 Denny End Road
    Waterbeach
    CB5 9PB Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Threeways 2 Denny End Road
    Waterbeach
    CB5 9PB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishBarrister66876770001
    WYNNE-JONES, Patrick Alban
    26 Church Street
    Stapleford
    CB2 5DS Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    26 Church Street
    Stapleford
    CB2 5DS Cambridge
    Cambridgeshire
    IrishCompany Director26500190001

    DESTINI BRIDGEMAN FIRTH FINANCIAL PLANNING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of trail & renewal income
    Créé le 25 nov. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the present and future rights titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the trail & renewal income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Prudential UK Services Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 08 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as kiln house, 4 kiln house yard, baldock street, royston, hertfordshire t/no HD361569. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 08 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of trail and renewal income
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 08 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from destini financial services group PLC (the borrower) and/or the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the present and future rights, title and interests in and benefits of the company in relation to insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 01 août 2003
    Livré le 08 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the following bank account of the company with the bank: account number 06006975; sort code: 12 08 81. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 déc. 1997
    Livré le 31 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a kiln house baldock street royston hertfordshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 déc. 1997
    Livré le 31 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 nov. 1996
    Livré le 14 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of an tenancy agreement of even date
    Brèves mentions
    Rent deposit £2,518.25.
    Personnes ayant droit
    • Sarah Jane Richards Jan Morgan Martin Wheale and Barbara Langlois as Trustees of Alzheimers Resarch Trust
    Transactions
    • 14 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 06 déc. 1995
    Livré le 15 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 1ST november 1995
    Brèves mentions
    The amount standing from time to time of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sarah Jane Richards, Joseph Pollock, Martin Wheale and Barbara Langlois as Trustees Ofalzheimer's Research Trust
    Transactions
    • 15 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 nov. 1994
    Livré le 03 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due form the company to the chargees as trustees of alzheimer's research trust
    Brèves mentions
    The original deposit of £2,250.00. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sarah Jane Richards
    • Joseph Pollock
    • Barbara Langlois
    • Martin Weale
    Transactions
    • 03 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0