02468112 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | 02468112 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02468112 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe 02468112 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Meridien House 42 Upper Berkeley Street W1H 5EP London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de 02468112 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 02468112 LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour 02468112 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed ashtenne holdings LIMITED\certificate issued on 01/11/13 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert William Game le 01 févr. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Cargil Management Services Limited en tant que secrétaire le 01 févr. 2013 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David James Lanchester en tant que secrétaire le 29 janv. 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 13 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE le 24 déc. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sir Philip Courtenay Thomas Warner le 11 juin 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Vinod Bachulal Vaghela en tant que directeur le 21 déc. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 12 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG01 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de 02468112 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 England |
| 38636470004 | ||||||||||
| GAME, Robert William | Administrateur | 42 Upper Berkeley Street W1H 5EP London Meridien House United Kingdom | United Kingdom | English | 139555050001 | |||||||||
| KEOGH, Mark William | Administrateur | Norfolk House 28 Kidmore Road Caversham RG4 7LU Reading | England | Irish | 62140690001 | |||||||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Administrateur | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840002 | |||||||||
| LANCHESTER, David James | Secrétaire | 1 Holly Close IG9 6HT Buckhurst Hill Essex | British | 7014460002 | ||||||||||
| LOWES, Richard Phillip | Secrétaire | 2 Westcott Keep RH6 9US Horley Surrey | British | 5785520001 | ||||||||||
| WATSON, Ian Richard | Secrétaire | Old Dove House Annables Lane AL5 3PR Harpenden Hertfordshire | British | 68256540001 | ||||||||||
| BODIE, John Emanuel | Administrateur | Flat 4 Providence House 18 Providence Court W1K 6PR London | United Kingdom | British | 19454160001 | |||||||||
| COLLINS, Peter William | Administrateur | The Oaks 23 Croft Road RG40 3HX Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 26086560001 | |||||||||
| GEE, Stephen Trevor | Administrateur | Petersfield House TN22 4EL Hadlow Down Sussex | British | 30701840001 | ||||||||||
| HAMBRO, James Daryl | Administrateur | 10 Park Place SW1A 1LP London | British | 53684400002 | ||||||||||
| JONES, Morgan Lewis | Administrateur | 4 Camden Close BR7 5PH Chislehurst Kent | England | British | 10146340003 | |||||||||
| MEADE, Karl Robert | Administrateur | Holly Mount Penn Road HP9 2TS Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 118074370001 | |||||||||
| MOORE, Richard | Administrateur | 88 Alzey Gardens AL5 5SZ Harpenden Hertfordshire | British | 73793650001 | ||||||||||
| STEVENS, Michael John | Administrateur | 32 Woodfield Park HP6 5QH Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 60348780002 | |||||||||
| VAGHELA, Vinod Bachulal | Administrateur | 99 Cathles Road Balham SW12 9LF London | England | British | 5689250001 | |||||||||
| WATSON, Ian Richard | Administrateur | Old Dove House Annables Lane AL5 3PR Harpenden Hertfordshire | England | British | 68256540001 |
02468112 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit with bank | Créé le 19 oct. 2009 Livré le 20 oct. 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge interest in each deposit and each account. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 22 juil. 2005 Livré le 04 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mezzanine security agreement | Créé le 22 juil. 2005 Livré le 01 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0