ASPECT VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASPECT VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02468264
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASPECT VENTURES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 avr. 199002 avr. 1990
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02 avr. 199002 avr. 1990
    LEGIBUS 1520 LIMITED08 févr. 199008 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021

    10 pagesLIQ03

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 27 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 janv. 2020

    LRESSP

    État du capital au 30 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 29 avr. 2018

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kirk Dyson Davis en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 01 mai 2016

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    19 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    30 nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2012 as it was not properly delivered

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    22 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    30 nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2011 as it was not properly delivered

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    22 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    30 nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2010 as it was not properly delivered

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524030001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BRIDGE, John Nigel
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    British39560640001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    British97033480001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591790001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444930001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022150001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish97033480001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    DYSON, Ian
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish154003250001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Colin David
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    Administrateur
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish1850120001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Administrateur
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritish895970001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Administrateur
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASPECT VENTURES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4872046
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ASPECT VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Amendment and restatement deed
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 21 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Truste Company Limited in Its Capacity as the "Issuer Security Trustee" and "Borrowergroup Security Trustee"
    Transactions
    • 21 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed of charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 31 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited as Agent and Trustee for the Borrower Secured Parties
    Transactions
    • 31 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Borrower group deed of charge
    Créé le 25 nov. 2004
    Livré le 13 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Trustee for the Borrower Secured Parties)
    Transactions
    • 13 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Ansty arms, coventry f/h t/n's WK251251 & WK251242. Bay horse, wigan f/h t/n's GM85094 & GM484585. Berkshire arms, nr newbury f/h t/n BK249470 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 09 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ASPECT VENTURES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 janv. 2020Commencement of winding up
    25 avr. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0