NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02470056
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED14 févr. 199014 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Steven Carl Wright en tant que directeur le 08 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Arthur Rushton en tant que directeur le 11 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Steven Carl Wright en tant qu'administrateur le 14 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    20 pagesAA

    Modification des détails de Greater London Enterprise Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England à 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY le 25 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England à 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY le 24 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 oct. 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS à 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN le 06 oct. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Michael Hofman en tant que secrétaire le 31 mai 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael Bernard Walsh en tant que secrétaire le 31 mai 2016

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOFMAN, Michael
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Secrétaire
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    209188220001
    MANSON, Christopher John
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish175493670001
    WALSH, Michael Bernard
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish74086660002
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    Secrétaire
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    GERVASIO, James Ernest Peter
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    British2093810001
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    Secrétaire
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    WALSH, Michael Bernard
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Secrétaire
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    159189680001
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    Administrateur
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    British12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    Administrateur
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    EnglandBritish44118740003
    ROGERS, Mary
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    Administrateur
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    British85165800001
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish44369580002
    WRIGHT, Steven Carl
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish232556880001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Newable Uk Holdings Limited
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    06 avr. 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Companies Register
    Numéro d'enregistrement5547054
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of share sale agreement
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 15 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of building contract
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 15 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on shares
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 15 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency
    Brèves mentions
    The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of building contract
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 14 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 14 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 20 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of legal charge
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 14 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 mai 1994
    Livré le 26 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 1993
    Livré le 13 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 nov. 1993
    Livré le 24 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 1993
    Livré le 26 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter
    Créé le 18 août 1993
    Livré le 01 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter
    Brèves mentions
    Cash sum of £4,000.
    Personnes ayant droit
    • Snowcem Pmc Limited
    Transactions
    • 01 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1992
    Livré le 20 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000
    Brèves mentions
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton.
    Personnes ayant droit
    • Blue Circle Industries PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1992
    Livré le 20 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0