AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 02470260 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Coburg House 1 Coburg St NE8 1NS Gateshead United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 janv. 2026 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 févr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 janv. 2025 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2025 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2024 | 5 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Livability le 19 janv. 2024 | 1 pages | CH02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 6 Mitre Passage London SE10 0ER England à Coburg House 1 Coburg St Gateshead NE8 1NS le 19 janv. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Peter Malcolm Woodall en tant qu'administrateur le 08 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Olumuyiwa Ayodele Laleye en tant que directeur le 31 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Livability en tant qu'administrateur le 09 mai 2022 | 2 pages | AP02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mr Olumuyiwa Ayodele Laleye en tant qu'administrateur le 07 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Leonie Jane Percy en tant qu'administrateur le 07 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kate Margaret Clare en tant que directeur le 07 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Ian Harvey en tant que secrétaire le 09 août 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Mark Ian Harvey en tant que directeur le 09 août 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Dr Mark Ian Harvey en tant que secrétaire le 31 mars 2020 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Sally Victoria Chivers en tant que directeur le 30 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Mark Ian Harvey en tant qu'administrateur le 31 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCY, Leonie Jane | Administrateur | 1 Coburg St NE8 1NS Gateshead Coburg House United Kingdom | England | British | 294613290001 | |||||||||
| WOODALL, Peter Malcolm | Administrateur | 1 Coburg St NE8 1NS Gateshead Coburg House United Kingdom | England | British | 84114610001 | |||||||||
| LIVABILITY | Administrateur | 1 Coburg Street NE8 1NS Gateshead Coburg House United Kingdom |
| 191393380001 | ||||||||||
| BOTHA, Alex | Secrétaire | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | 249082720001 | |||||||||||
| GOULTY, Graham Victor | Secrétaire | 6 Longdean Park DH3 4DF Chester Le Street County Durham | British | 62503840001 | ||||||||||
| HARVEY, Mark Ian, Dr | Secrétaire | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | 268576160001 | |||||||||||
| LANGWORTH, Michael Peter Anthony | Secrétaire | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | 208106820001 | |||||||||||
| MUNJERI, Calister | Secrétaire | c/o Prospects Honey End Lane RG30 4EL Reading 69 | 205997670001 | |||||||||||
| STONER, Peter James | Secrétaire | 12 Coutts Road Walkergate NE6 4RB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 18972310001 | ||||||||||
| WILKINSON, Erica Ross | Secrétaire | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | 255224260001 | |||||||||||
| WILSON, Geoffrey Gordon | Secrétaire | c/o Prospects Honey End Lane RG30 4EL Reading 69 | 193606750001 | |||||||||||
| ANDERSON, Stephen | Administrateur | The Granary, East Farm Front Street, Newbottle DH4 4ER Houghton Le Spring Tyne & Wear | England | British | 16525770002 | |||||||||
| ASHTON, Paul William | Administrateur | Hermitage Cottages Exwick Hill EX4 2AL Exeter 4 England | England | British | 69325860003 | |||||||||
| ATKIN, Liane Jennifer | Administrateur | 23 Beechcroft Humshaugh NE46 4DN Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 122674730001 | |||||||||
| BENTLEY, David John | Administrateur | South Drive SM2 7PN Sutton 42 Surrey England | England | British | 109589040001 | |||||||||
| BLANCHFLOWER, Isabel Mary | Administrateur | 29 Ravens Worth Road Dunston NE11 9AB Gateshead Tyne And Wear | British | 18972330001 | ||||||||||
| BOTHA, Alex | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | England | British | 260285620001 | |||||||||
| CHIVERS, Sally Victoria | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | United Kingdom | British | 171373210001 | |||||||||
| CLARE, Kate Margaret | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | England | British | 163982330002 | |||||||||
| CURRY, Donald Thomas Younger, Lord | Administrateur | Middle Farm Barrasford NE48 4DA Hexham Northumberland | United Kingdom | British | 52925230001 | |||||||||
| CURRY, Jonathan Robert Younger | Administrateur | Dryburn Park DH1 5AD Durham 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 157517670001 | |||||||||
| CURRY, Matthew Stephen | Administrateur | 410 - 420 West Road NE5 2ER Newcastle Upon Tyne Freeman House United Kingdom | United Kingdom | British | 157091880001 | |||||||||
| ENGLAND, Helen Margaret | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | England | British | 161838630001 | |||||||||
| FAIRBAIRN, Alison | Administrateur | Millfield Avenue NE3 4TB Newcastle Upon Tyne 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 43458730001 | |||||||||
| GRAHAM, David | Administrateur | 53 Slaley Park Slaley NE47 0BG Hexham Northumberland | British | 104383890001 | ||||||||||
| GRANT, Alexander Matheson | Administrateur | 97 Whinneyfield Road Walkergate NE6 4RR Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 18972320001 | ||||||||||
| HALL, Colin | Administrateur | 52 Beach Avenue NE26 1DZ Whitley Bay Tyne & Wear | British | 73646500001 | ||||||||||
| HARVEY, Mark Ian | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | England | British | 10508320001 | |||||||||
| KING LEWIS, Anne Margaret | Administrateur | The Meadows Station Road NE45 5AX Corbridge On Tyne Northumberland | British | 44212830001 | ||||||||||
| LALEYE, Olumuyiwa Ayodele | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | England | Nigerian,British | 203763030002 | |||||||||
| LAVENDER, Michael Charles, Dr | Administrateur | Wansdyke NE61 3RN Morpeth 34 Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 71257890001 | |||||||||
| LEDDEN, Michael Joseph | Administrateur | c/o Prospects Honey End Lane RG30 4EL Reading 69 | England | British | 179645840001 | |||||||||
| MAYLAND, Richard Derrick | Administrateur | c/o Prospects Honey End Lane RG30 4EL Reading 69 | United Kingdom | British | 115285770001 | |||||||||
| MELL, Elizabeth Jane | Administrateur | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | United Kingdom | English | 212396960001 | |||||||||
| MENZIES, John Henry Bosley | Administrateur | 14 Delves Wood Road HD4 7AS Huddersfield West Yorkshire | British | 37847420005 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AT HOME IN THE COMMUNITY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospects For People With Learning Disabilities | 06 avr. 2016 | Mitre Passage SE10 0ER London 6 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0