DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL

DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 02475089
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    • (6712) /

    Où se situe DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    Adresse du siège social
    One Cabot Square
    London
    E14 4QJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DLJ (UK) LIMITED09 juil. 199009 juil. 1990
    HACKREMCO (NO.575) LIMITED28 févr. 199028 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 févr. 2011

    État du capital au 23 févr. 2011

    • Capital: USD 1.5
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    8 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Susannah Louise Aliker en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Long en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Paul Edward Hare en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Studd en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Long le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Paul Edward Hare le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Lester Studd le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    21 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    9 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    British23220350004
    ALIKER, Susannah Louise
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    United KingdomBritish99766410001
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United KingdomBritish23220350004
    MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomAmerican,Cypriot73091230001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Secrétaire
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HORNSEY, Nicholas John
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    Secrétaire
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    British50650950002
    SIEGLER, Thomas Edmund
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    Secrétaire
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    American47358850001
    AITCHINSON, Carolyn Jane
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    Administrateur
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    British62873110004
    ALEXANDRE, James Lawrence
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    Administrateur
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    American63091430001
    BRETTON, Nigel Paul
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    British75188550001
    BURROWES, Kevin James
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    British105411790001
    CATANIA, Alejandro Miguel
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    Administrateur
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    Itialian74299160001
    DISLEY, Kevin John
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147923330001
    GORMLEY, Peter Vincent
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    Usa52530740001
    GREEN, Darryl John
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish60672010001
    HALE, Charles Martin
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    Administrateur
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    United KingdomBritish105772830001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Administrateur
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HART, Mark
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    Administrateur
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    British67366820001
    HIARD, Michael Henry
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British18403810002
    HOHMANN III, Frank Lynn
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    Administrateur
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    American33491720001
    KAWKABANI, Nagi Robert
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    Administrateur
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    United KingdomCanadian33491730003
    LONG, David
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish126956520001
    MASMEJEAN, Pierre Olivier
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    Administrateur
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    French49032650001
    PETRILLI, Anthony Mario
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    British54390740001
    PIKE, Catherine Elizabeth
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    Administrateur
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    British45313610002
    RATTNER, Steven Charles
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    Administrateur
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    American70635020001
    ROBINSON, Nicholas Ian
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    British44793820001
    ROE, Steven Robin Charles
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    British34616850002
    SANTS, Hector William Hepburn
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British1576920001
    SEET, Joe Lip Poh
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    Administrateur
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    British52359050001
    SMITH, Martin, Sir
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    Administrateur
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    United KingdomBritish35552480001
    STUDD, Kevin Lester
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish86302520001
    WRIGHT, Geraldine Helen
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    Administrateur
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    British83599210001

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Créé le 06 sept. 1996
    Livré le 11 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All borrowings (meaning overdraft, fixed term advances or securities borrowing, or any other extension of credit by morgan guaranty trust company of new york to the borrower, in whatever form, that relates to or results from the borrower's use of the euroclear system, as well as any fees or accrued interest with respect thereto), and other obligations, in whatever form, that relate to or result from the borrower's use of the euroclear system, now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to morgan guaranty brussels and to any other office of morgan guaranty trust company of new york
    Brèves mentions
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 11 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 22 sept. 1992
    Livré le 07 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities, together with all benefits arising therefrom and not transferred or delivered by or at the direction of the stock exchange to the company.
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and Republic of Ireland Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0