DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 02475089 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?
| Adresse du siège social | One Cabot Square London E14 4QJ |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 8 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Susannah Louise Aliker en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 20 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Long en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Paul Edward Hare en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Studd en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Long le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Paul Edward Hare le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Lester Studd le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 21 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 21 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 9 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2006 | 20 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARE, Paul Edward | Secrétaire | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | British | 23220350004 | ||||||
| ALIKER, Susannah Louise | Administrateur | Cabot Square E14 4QJ London 1 | United Kingdom | British | 99766410001 | |||||
| HARE, Paul Edward | Administrateur | Cabot Square E14 4QJ London One | United Kingdom | British | 23220350004 | |||||
| MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors | Administrateur | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | American,Cypriot | 73091230001 | |||||
| HARRIMAN, John Patrick William | Secrétaire | Flat 3 6 Tedworth Square SW3 4DY London | British | 49828030001 | ||||||
| HORNSEY, Nicholas John | Secrétaire | Eremue 8 The Avenue TW12 3RS Hampton Middlesex | British | 50650950002 | ||||||
| SIEGLER, Thomas Edmund | Secrétaire | 39 Wildwood Drive Dix Hills New York 11746 Usa | American | 47358850001 | ||||||
| AITCHINSON, Carolyn Jane | Administrateur | 126 Palace Gardens Terrace W8 4RT London | British | 62873110004 | ||||||
| ALEXANDRE, James Lawrence | Administrateur | 33 Blomfield Road W9 1AA London | American | 63091430001 | ||||||
| BRETTON, Nigel Paul | Administrateur | Blue Clay 33 Rose Walk AL4 9AA St Albans Hertfordshire | British | 75188550001 | ||||||
| BURROWES, Kevin James | Administrateur | Samuelson House Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LP Cobham Surrey | British | 105411790001 | ||||||
| CATANIA, Alejandro Miguel | Administrateur | 90 Palace Gardens Terrace W8 4RF London | Itialian | 74299160001 | ||||||
| DISLEY, Kevin John | Administrateur | 18 Larksway CM23 4DG Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 147923330001 | |||||
| GORMLEY, Peter Vincent | Administrateur | Pinehill Sunning Avenue SL5 9PW Sunningdale Berkshire | Usa | 52530740001 | ||||||
| GREEN, Darryl John | Administrateur | Wychden Wildernesse Avenue TN15 0EA Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 60672010001 | |||||
| HALE, Charles Martin | Administrateur | 33 Lyall Mews SW1X 8DJ London | United Kingdom | British | 105772830001 | |||||
| HARRIMAN, John Patrick William | Administrateur | Flat 3 6 Tedworth Square SW3 4DY London | British | 49828030001 | ||||||
| HART, Mark | Administrateur | 39 Gilhams Avenue SM7 1QW Banstead Surrey | British | 67366820001 | ||||||
| HIARD, Michael Henry | Administrateur | Foxes High Wych Road CM21 OHH Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 18403810002 | ||||||
| HOHMANN III, Frank Lynn | Administrateur | 242 Hendrickson Drive Princeton Junction New Jersey 08550 Usa | American | 33491720001 | ||||||
| KAWKABANI, Nagi Robert | Administrateur | 47 Lennox Gardens SW1 London | United Kingdom | Canadian | 33491730003 | |||||
| LONG, David | Administrateur | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | British | 126956520001 | |||||
| MASMEJEAN, Pierre Olivier | Administrateur | 66 Redcliffe Road SW10 9NQ London | French | 49032650001 | ||||||
| PETRILLI, Anthony Mario | Administrateur | 18 Icklingham Road KT11 2NQ Cobham Surrey | British | 54390740001 | ||||||
| PIKE, Catherine Elizabeth | Administrateur | 75 Noel Road N1 8HE London | British | 45313610002 | ||||||
| RATTNER, Steven Charles | Administrateur | 408 Grace Church Street Rye New York Ny 10580 Usa | American | 70635020001 | ||||||
| ROBINSON, Nicholas Ian | Administrateur | Beechwood Little Orchards Salvington Hill BN13 3BD Worthing West Sussex | British | 44793820001 | ||||||
| ROE, Steven Robin Charles | Administrateur | 10 Eastwood Bridgewater Road KT13 0EG Weybridge Surrey | British | 34616850002 | ||||||
| SANTS, Hector William Hepburn | Administrateur | Court Farm Worminghall HP18 9LD Aylesbury Buckinghamshire | British | 1576920001 | ||||||
| SEET, Joe Lip Poh | Administrateur | 6 Padbrook RH8 0DW Oxted Surrey | British | 52359050001 | ||||||
| SMITH, Martin, Sir | Administrateur | 4 Essex Villas W8 7BN London | United Kingdom | British | 35552480001 | |||||
| STUDD, Kevin Lester | Administrateur | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | British | 86302520001 | |||||
| WRIGHT, Geraldine Helen | Administrateur | 30 High Gables 1 Scotts Avenue BR2 0NB Bromley Kent | British | 83599210001 |
DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system | Créé le 06 sept. 1996 Livré le 11 sept. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All borrowings (meaning overdraft, fixed term advances or securities borrowing, or any other extension of credit by morgan guaranty trust company of new york to the borrower, in whatever form, that relates to or results from the borrower's use of the euroclear system, as well as any fees or accrued interest with respect thereto), and other obligations, in whatever form, that relate to or result from the borrower's use of the euroclear system, now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to morgan guaranty brussels and to any other office of morgan guaranty trust company of new york | |
Brèves mentions All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 22 sept. 1992 Livré le 07 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities, together with all benefits arising therefrom and not transferred or delivered by or at the direction of the stock exchange to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0