NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02475402
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    • (7222) /

    Où se situe NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAMBRIDGE ANIMATION SYSTEMS LIMITED22 mars 199022 mars 1990
    FELTONIAN LIMITED28 févr. 199028 févr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2008

    9 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2007

    7 pagesAA

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    6 pages363a

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cambridge animation systems LIMITED\certificate issued on 19/01/09
    3 pagesCERTNM

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 08 janv. 2009

    2 pages1.3

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    5 pages1.4

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 22 sept. 2008

    9 pages1.3

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 22 sept. 2007

    10 pages1.3

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2006

    9 pagesAA

    Divers

    Supervisor's report
    5 pagesMISC

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 22 sept. 2006

    2 pages1.3

    legacy

    7 pages363s

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2005

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288b

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 22 sept. 2005

    3 pages1.3

    Qui sont les dirigeants de NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    Secrétaire
    Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    79
    81576980001
    SLEVIN, Cormac Brian
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    62 Brampton Road
    CB1 3HL Cambridge
    Cambridgeshire
    Irish98972470001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Secrétaire
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Secrétaire
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    British3751430003
    SHIRREN, Gerry
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Secrétaire
    Kiltale
    IRISH Dunsany
    Co Meath
    Ireland
    Irish97685400001
    VIS, Annemarie Mirjam Frederique
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    Secrétaire
    37 Martingale Close
    CB4 3TA Cambridge
    British52939100001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    Secrétaire
    Charity Farmhouse
    Brinkley
    CB8 0SE Newmarket
    Suffolk
    British89506550001
    PS LAW SECRETARIES LIMITED
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    Secrétaire
    2nd Floor
    79 Knightsbridge
    SW1X 7RB London
    81576980001
    ABBOTT, Raymond James
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    Administrateur
    44 Coillesdene Avenue
    EH15 2JR Edinburgh
    British65699620002
    BAHNS, Robert Harold
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    Administrateur
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    British64794090001
    BARRETT, Philip James, Dr
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    16 Kings Road
    PE19 1LD St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish198025600001
    BEREND, Andrew Louis Charles
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Administrateur
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    British24724970005
    CARRIGAN, Thomas Jay
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    Administrateur
    464 Notre Dame Road
    91711 Claremont
    Los Angeles
    Usa
    American60077320001
    FERRIS, Gavin Robert, Dr
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    29c Shanrod Road
    Katebridge
    BT32 5PG Banbridge
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish107911580001
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    Administrateur
    34 Mornington Crescent
    NW1 7RE London
    United KingdomBritish50715100002
    FLORENCE, Peter Charles
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    Administrateur
    34 Grafton Street
    CB1 1DS Cambridge
    British50715100001
    HAYMAN, Anne Carolyn
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    Administrateur
    36 Lawford Road
    NW5 2LN London
    EnglandBritish32391350001
    HOLLAND, Stephen John William
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    35 Woodlands Park
    CB3 0QB Girton
    Cambridgeshire
    British79873930001
    JACKSON, John Bernard Haysom
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    Administrateur
    Summit House
    Red Lion Square
    WC1R 4QB London
    United KingdomBritish98731480001
    KELLY, William
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    Administrateur
    10 Peak Lane
    Portola Valley
    94028 California
    Usa
    American46464350001
    KORDA, Alexander Vincent
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    Administrateur
    Flat 7 8 St Quintin Avenue
    W10 6NU London
    United KingdomBritish110996140001
    MCCALL, Ruth
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    Administrateur
    18 Milman Road
    Queens Park
    NW6 6EJ London
    British51783880001
    MITCHELL, John Ross, Dr
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    123a London Road
    SG18 8EF Biggleswade
    Bedfordshire
    British54883260001
    O'CONNOR, Christopher Patrick, Mr.
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Willow Cottage
    School Lane
    CB23 4ND Boxworth
    Cambridgeshire
    EnglandBritish3751430003
    OSBORN, Peter Gordon
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Northchurch Farm Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    British28389710001
    PETTMAN, Michael George
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    Administrateur
    The Ranch
    High Street
    SL6 5LT Hurley
    Bucks
    British23702430001
    RAMSAY, Michael
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    Administrateur
    13060 Alta Lane North
    Los Altos Hills
    California 94022
    Usa
    UsaBritish72705850001
    SCOGGINS, Ian Maxwell
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    Administrateur
    High Thicket
    Dockenfield
    GU10 4HB Farnham
    Surrey
    British54583190001
    SOMPER, Nicholas John
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    Administrateur
    55 Brookland Rise
    NW11 6DT London
    British59505050001
    STEEL, Andrew Dewar
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Flat 2 3 Dean Path
    EH4 3BG Edinburgh
    Midlothian
    British14788330002
    SWINSTEAD, Philip Edgar
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    Administrateur
    Flat 5
    60-61 Cheyne Walk
    SW3 5LX London
    British101634050001
    TYLER, Brian David
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    64 Cavendish Avenue
    CB1 7UT Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish76611270001
    WATT, Mark
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    14 Beaufort Place
    Thompsons Lane
    CB5 8AG Cambridge
    Cambridgeshire
    British56960450001

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2001
    Livré le 18 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 mars 1997
    Livré le 19 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 13TH march 1997 and the debenture
    Brèves mentions
    All of the assets and undertakings of the company except interest in leaseholds as at 13/3/97; shares in animax animation consortium limited and charges in respect of rent deposits not exceeding £50,000.
    Personnes ayant droit
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transactions
    • 19 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 mars 1997
    Livré le 28 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £3,000 plus interest.
    Personnes ayant droit
    • Leonard Robert Martin
    Transactions
    • 28 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rent deposit
    Créé le 14 sept. 1995
    Livré le 15 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease made 14TH september 1995
    Brèves mentions
    The sum of £8,800.00 being the initial deposit placed in a deposit account by cambridge homes limited under the terms of the deed.
    Personnes ayant droit
    • Cambridge Homes Limited
    Transactions
    • 15 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Monument Trust Company Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £55,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ivory & Sime Enterprise Capital PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • John Jackson
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Colin West
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Walbrook Trustees (Guernsey) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible loan stock debenture
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Korda Seed Capital Fund Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 1993
    Livré le 20 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 18 sept. 1992
    Livré le 26 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date and this charge
    Brèves mentions
    £14,900 and any other amount standing to the credit of the account.
    Personnes ayant droit
    • The Oceana Consolidated Company PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEW SOFTWARE SOLUTIONS LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 sept. 2002Date of meeting to approve CVA
    08 janv. 2009Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Alfred Lettice
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge
    practitioner
    Peters Elworthy & Moore
    Salisbury House
    CB1 2LA Station Road
    Cambridge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0