CROWN SPORTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROWN SPORTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02476401
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CROWN SPORTS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CROWN SPORTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CROWN SPORTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CROWN SPORTS PLC22 sept. 200022 sept. 2000
    GOLF CLUB HOLDINGS PLC16 avr. 199816 avr. 1998
    CLUBPARTNERS INTERNATIONAL PLC06 avr. 199506 avr. 1995
    ARMADILLO HOLDINGS PLC28 févr. 199428 févr. 1994
    LAMBOURNE GOLF CLUB PLC11 févr. 199111 févr. 1991
    INDEXSTRONG PUBLIC LIMITED COMPANY02 mars 199002 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de CROWN SPORTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CROWN SPORTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 sept. 2018

    6 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Peter William Denby Roberts en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jacques De Bruin en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY United Kingdom à 15 Canada Square London E14 5GL le 29 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 sept. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 mars 2016

    État du capital au 22 mars 2016

    • Capital: GBP 14,538,400.25
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall Doncaster South Yorkshire DN3 1QR à C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY le 06 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 024764010009 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter William Denby Roberts le 08 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Adam John Gordon Bellamy en tant que secrétaire le 28 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ross Steven Chester en tant que directeur le 28 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin Long en tant que directeur le 28 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Arthur Mccoll en tant que directeur le 28 mai 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CROWN SPORTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    198433730001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishDirector172693720002
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector100141010001
    BARTON, Michael William
    Box 174 89 Pall Mall
    SW1Y 5HS London
    Secrétaire
    Box 174 89 Pall Mall
    SW1Y 5HS London
    British98950580001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Secrétaire
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    BritishDirector4878250001
    GLEW, Steven Peter
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    British88254510001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    BritishChief Financial Officer124301460001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector114849640001
    STUTTAFORD, John Cyril
    5 The Chine
    Wrecclesham
    GU10 4NN Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    5 The Chine
    Wrecclesham
    GU10 4NN Farnham
    Surrey
    British34310500001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    Secrétaire
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    BritishDirector71126560002
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    Secrétaire
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    38636470004
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    Secrétaire
    22 Melton Street
    NW1 2BW London
    38636470004
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    Administrateur
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomSouth AfricanDirector198346420001
    CARTER, David Charles Merryck
    Two Oaks Longfield Terrace
    Nags Head Lane
    HP16 0ER Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Two Oaks Longfield Terrace
    Nags Head Lane
    HP16 0ER Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director56462450004
    CHAPMAN, Jeffrey Robert
    Stourton Manor
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Manor
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    AustralianCompany Director61818780002
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector137527310001
    DIXON, Hugh Ward
    Manor Farmhouse
    Romsey Road Pitt
    SO22 9QW Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Farmhouse
    Romsey Road Pitt
    SO22 9QW Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director42714140001
    GLEW, Steven Peter
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NZ Welwyn
    Hertfordshire
    BritishFinance Director88254510001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer124301460001
    GRAY, David Charles Norreys
    Ivy Farm
    Smithfield End
    MK17 OSP Swanbourne
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ivy Farm
    Smithfield End
    MK17 OSP Swanbourne
    Buckinghamshire
    BritishAccountant74068140001
    GREALEY, Martyn
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    Administrateur
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director125401590001
    HABGOOD, Nicholas John
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishVenture Capitalist76793280001
    HARDGRAVE, Mark William
    38 New Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    Administrateur
    38 New Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    AustralianCompany Director84818460001
    HARDGRAVE, Mark William
    38 New Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    Administrateur
    38 New Street
    Brighton
    Victoria
    3186
    Australia
    AustralianCompany Director84818460001
    KELLY, Maurice William
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director89366130001
    KEYS, Alan Ramon
    Fernfield 6 Queensgate
    KT11 2TG Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Fernfield 6 Queensgate
    KT11 2TG Cobham
    Surrey
    BritishConsultant26266090002
    KNIGHT, Martin Peter
    Waterloo Farm
    Fulbrook
    OX18 4BZ Burford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Waterloo Farm
    Fulbrook
    OX18 4BZ Burford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director64447520001
    LEAVER, Marcus Edward
    138 Wardo Avenue
    SW6 6RD London
    Administrateur
    138 Wardo Avenue
    SW6 6RD London
    BritishRestauranteur76685980001
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector125885350001
    LUMLEY, Colin John
    Pond Villas Littlefield Green
    White Waltham
    SL6 3JW Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Pond Villas Littlefield Green
    White Waltham
    SL6 3JW Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomAustralianCompany Director46813030001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritishDirector139099550001
    NEWMAN, Robert Andrew
    Willow Corner
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Willow Corner
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham
    Buckinghamshire
    BritishGolf Director33506900001
    PEARL, David Brian
    311 Portland Road
    Glacis Road
    Gibraltar
    Administrateur
    311 Portland Road
    Glacis Road
    Gibraltar
    BritishCompany Director84357910002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROWN SPORTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03224406
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CROWN SPORTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 juin 2014
    Livré le 10 juin 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 10 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental security and confirmation deed
    Créé le 30 août 2011
    Livré le 13 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2006
    Livré le 03 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land, shares, investments, plant and machinery, book debts, non trading debts, accounts held with finance parties, intellectual property rights, goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 03 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over cash collateral security account
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 09 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and interest in the cash collateral security account and the charged balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 09 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 09 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies,liabilities and obligations whatsoever due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including (I) the f/hold property known as northwood squash club,chestnut ave,northwood,midd'x; AGL37538; (ii) f/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks road,halstead sevenoaks; K588424 and K685755; (iii) l/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks rd,halstead,sevenoaks; K725693; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 1998
    Livré le 07 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Loan stock instrument
    Créé le 06 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this loan stock instrument
    Brèves mentions
    95. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • European Golf Club Investment Limited
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 sept. 1992
    Livré le 22 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1992
    Livré le 18 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at burnham, south bucks, t/nos.bm 39509, bm 153010 and bm 162954 see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CROWN SPORTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2019Dissolved on
    05 sept. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0