PRC PUBLISHING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRC PUBLISHING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02477813
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRC PUBLISHING LIMITED ?

    • Édition de livres (58110) / Information et communication

    Où se situe PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    43 Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE PROMOTIONAL REPRINT COMPANY LIMITED06 mars 199006 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2016

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1 Gower Street London WC1E 6HD à 43 Great Ormond Street London WC1N 3HZ le 24 nov. 2016

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 24 août 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 17/08/2016
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2015

    7 pagesAA

    Nomination de Mrs Zana Samantha Hanks en tant que secrétaire le 19 mai 2015

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2015

    État du capital au 02 avr. 2015

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Allan Conan Sams en tant que secrétaire le 26 mars 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Allan Conan Sams en tant que secrétaire le 26 mars 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2014

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Old Magistrates Court 10 Southcombe Street London W14 0RA* le 07 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2014

    État du capital au 17 avr. 2014

    • Capital: GBP 110,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Robin Wood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Proffit en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANKS, Zana Samantha
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Secrétaire
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    197807060001
    POWELL, Polly Augusta Marchant
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Administrateur
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    EnglandBritishPublisher110229300002
    HAILSTONE, Timothy
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    Secrétaire
    10 Talbot Road
    Highgate
    N6 4QR London
    British13509200001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    British33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    British44857580002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    RANDS, Neil David George
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    151 Abbotts Drive
    HA0 3SH North Wembley
    Middlesex
    British21966770002
    SAMS, Allan Conan
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    Secrétaire
    Gower Street
    WC1E 6HD London
    1
    England
    BritishLegal107693020001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    Secrétaire
    55 Trinity Road
    SW19 8QY Wimbledon
    BritishPublisher110229220004
    BARRY, Stephen Jeffrey
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    Administrateur
    3 Darnley Terrace
    W11 4RL London
    BritishDirector24468010001
    BROWN, Cameron Michael
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    Administrateur
    10 Hillside
    SW19 4NH London
    United KingdomBritishCompany Director1654670001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Director36186210001
    COLLINS, Samuel Alexander Mark
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    Administrateur
    71 Cadogan Square
    SW1 London
    BritishPublisher63626140001
    HAILSTONE, Timothy
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    Administrateur
    Flat 6 28 Colville Road
    W11 2BS London
    BritishCompany Director13509200002
    JAITLY, Suneel
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Administrateur
    27 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director44857620002
    LASSMAN, Peter
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    Arkley Manor Rowley Lane
    Arkley
    EN5 3HS Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector3374500001
    LEAVER, Marcus Edward
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    Administrateur
    39 Faroe Road
    W14 0EL London
    BritishDirector76685980003
    LENTON, Paul Richard
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    Administrateur
    27 Great Bushey Drive
    Totteridge
    N20 8QN London
    EnglandBritishFinance Director82173510001
    MESSHAM, Joanne
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    Administrateur
    9 Ebner Street
    Wandsworth
    SW18 1BT London
    BritishCompany Director41015430002
    NEEDLEMAN, John Elliot
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Kerry 20 Christchurch Crescent
    WD7 8AH Radlett
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant20117690001
    NESS, Robert James
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    247 Icknield Way
    SG6 4UE Letchworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director33929080001
    PHILLIPS, Kevin
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    BritishAccountant44857580002
    PROFFIT, David Macer, Mr.
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Administrateur
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    United KingdomBritishPublisher109190190002
    SANDERSON, Charles
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    Administrateur
    105 Castlehaven Road
    Camden
    NW1 8SJ London
    BritishFinance Director88028580001
    SIMPSON, Lisa Mary
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    45 Lower Street
    GU27 2NY Haslemere
    Surrey
    BritishPublisher74052460002
    STRACHAN, David Alistair
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    Administrateur
    Summerhill Cottage Summerhill Road
    DA1 2LP Dartford
    Kent
    United KingdomBritishFinancial Director56866560001
    WOOD, Robin Lee Knoyle
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    Administrateur
    Old Magistrates Court
    10 Southcombe Street
    W14 0RA London
    UkBritishPublisher110229220004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PRC PUBLISHING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Polly Augusta Marchant Powell
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    06 avr. 2016
    Great Ormond Street
    WC1N 3HZ London
    43
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    PRC PUBLISHING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 mars 2007
    Livré le 16 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 09 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Group PLC
    Transactions
    • 09 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 09 avr. 2001
    Livré le 26 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Books PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 juin 2000
    Livré le 24 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Conance Limited
    Transactions
    • 24 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 oct. 1999
    Livré le 20 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 02 sept. 1998
    Livré le 10 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Stock trust deed and charge over assets
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 01 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all monies due in relation to the £367,000 10% fixed rate loan stock issued by the company and secured by the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all intellectual property rights belonging to the company. By way of a floating charge the company's undertaking and all their other property assets and undertakings both present and future including any uncalled capital together with any assets and rights mortgaged or charged under the fixed charge if and so far as such mortgage or charge is ineffective as a fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Limecourt Investments Limited
    Transactions
    • 01 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 22 déc. 1995
    Livré le 05 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    The initial rent deposit of £8,821 plus accrued net interest.
    Personnes ayant droit
    • Kestrel Properties Limited
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 oct. 1995
    Livré le 07 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Co.
    Transactions
    • 07 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit account agreement
    Créé le 28 févr. 1995
    Livré le 03 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease of even date
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of the rent deposit account opened pursuant to the terms of this deed.
    Personnes ayant droit
    • Cadogan Estates Limited
    Transactions
    • 03 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 juil. 1994
    Livré le 02 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit account agreement
    Créé le 17 nov. 1992
    Livré le 19 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 14/11/92
    Brèves mentions
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 17TH november 1992.
    Personnes ayant droit
    • Cadogan Estates Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 1991
    Livré le 19 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0