ISI DISTRIBUTION LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéISI DISTRIBUTION LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02478802
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ISI DISTRIBUTION LTD ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Adresse du siège social
    Redwood 2 Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IQ SYS LIMITED05 oct. 200605 oct. 2006
    INTERQUAD SYSTEMS LIMITED29 déc. 200029 déc. 2000
    INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED14 mai 199814 mai 1998
    EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED03 juil. 199003 juil. 1990
    POWERBAND LIMITED08 mars 199008 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 août 2018

    9 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    4 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 août 2017

    LRESSP

    État du capital au 27 juin 2017

    • Capital: GBP 100
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 20/06/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2016

    État du capital au 19 juil. 2016

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    17 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Appointment of dirs 12/10/2015
    RES13

    Cessation de la nomination de Peter Hubbard en tant que directeur le 29 juin 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Watts en tant qu'administrateur le 26 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Howard Tuffnail en tant qu'administrateur le 26 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andy Gass en tant qu'administrateur le 26 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2015

    État du capital au 02 juin 2015

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Eccleston en tant que directeur le 28 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mars 2014

    État du capital au 25 mars 2014

    • Capital: GBP 1,100
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2014 au 30 juin 2014

    3 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OLLIS, Rachel Anne
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    178574660001
    GASS, Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish49358720003
    TUFFNAIL, Howard
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United KingdomCanadian202334610001
    WATTS, David
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish160214110001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    British7347950001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Secrétaire
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    CORNWALL, Douglas Charles
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    United KingdomBritish84669710001
    ECCLESTON, Paul Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139879610001
    FANE, Sean Paul
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish67225450007
    HERRON, Bonnie Lea
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    Administrateur
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    American16958430002
    HUBBARD, Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167795150001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JAMES, Philip John
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118754760002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MCCORMICK, John Edgar
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    Administrateur
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    American16958460001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    Administrateur
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    United KingdomBritish72170360001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    Administrateur
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    EnglandBritish7347950001
    RIGBY, James Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish88633720001
    RIGBY, Peter, Sir
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish15654920006
    STRANGE, John Leland
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    Administrateur
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    American16958470001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Administrateur
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ISI DISTRIBUTION LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    06 avr. 2016
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement1769690
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ISI DISTRIBUTION LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A fixed charge on book and other debts
    Créé le 04 nov. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal assignment
    Créé le 04 nov. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 04 nov. 2011
    Livré le 09 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 09 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 14 oct. 2010
    Livré le 27 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 27 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed & floating charge
    Créé le 15 mai 2009
    Livré le 27 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 27 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 2007
    Livré le 03 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland, as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 03 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 juin 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 23 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 nov. 2000
    Livré le 07 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 mai 1999
    Livré le 13 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transactions
    • 13 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 16 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Isc (Guernsey) Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 janv. 1999
    Livré le 02 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1998
    Livré le 23 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ISI DISTRIBUTION LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 août 2017Commencement of winding up
    16 janv. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0