LASIG REALISATIONS 2 LIMITED

LASIG REALISATIONS 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLASIG REALISATIONS 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02479566
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration

    Où se situe LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ship Canal House, 8th Floor, 98
    King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAS IGUANAS LIMITED01 juin 200601 juin 2006
    METRODINER LIMITED11 avr. 199411 avr. 1994
    TASKMAP LIMITED12 mars 199012 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    37 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Nomination d'un administrateur

    pagesAM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Démission d'un administrateur

    4 pagesAM15

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    4 pagesAM19

    Nomination d'un administrateur

    pagesAM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    47 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    46 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    5 pagesAM19

    Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House, 8th Floor, 98 King Street Manchester M2 4WU le 29 mars 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    66 pagesAM10

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 024795660041

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 024795660042

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 024795660040

    11 pagesMR05

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 024795660039

    11 pagesMR05

    Certificat de changement de nom

    Company name changed las iguanas LIMITED\certificate issued on 29/10/20
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de James Forrester Spragg en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Adrian Rowland Walker en tant que directeur le 08 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    5 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    99 pagesAM03

    Qui sont les dirigeants de LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    237559570001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    201177670001
    JAYA WICKREMA, Ajith
    7 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BG Bristol
    Southfield Lodge
    Secrétaire
    7 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BG Bristol
    Southfield Lodge
    British68930300003
    JAYA WICKREMA, Ajith
    Tiffany Cottage
    45 Horse Street, Chipping Sodbury
    BS37 6DA Bristol
    Avon
    Secrétaire
    Tiffany Cottage
    45 Horse Street, Chipping Sodbury
    BS37 6DA Bristol
    Avon
    British68930300001
    POLLOCK, Kieron John
    7 Stranks Close
    Highworth
    SN6 7DQ Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    7 Stranks Close
    Highworth
    SN6 7DQ Swindon
    Wiltshire
    British93019400002
    WEBB, Andrew
    55 Hampden Close
    Yate
    BS17 5UP Bristol
    Avon
    Avon
    Secrétaire
    55 Hampden Close
    Yate
    BS17 5UP Bristol
    Avon
    Avon
    British26487570001
    ALI, Eren
    Stone
    GL13 9JY Berkeley
    Old Coach House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Stone
    GL13 9JY Berkeley
    Old Coach House
    Gloucestershire
    United KingdomBritish25072430004
    CRAINE, Alan
    15 St Werburghs Road
    BS2 9XZ Bristol
    Avon
    Administrateur
    15 St Werburghs Road
    BS2 9XZ Bristol
    Avon
    British124046240001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187907210001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    HILL, Steven Alan
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    4
    England
    Administrateur
    Alma Road
    Clifton
    BS8 2BY Bristol
    4
    England
    EnglandBritish96715560005
    HUGHES, Paul Martyn
    Little Oaks
    Staplehay, Trull
    TA3 7HB Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Little Oaks
    Staplehay, Trull
    TA3 7HB Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish63902300003
    JAYA WICKREMA, Ajith
    7 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BG Bristol
    Southfield Lodge
    Administrateur
    7 Southfield Road
    Westbury-On-Trym
    BS9 3BG Bristol
    Southfield Lodge
    United KingdomBritish68930300003
    KEMP-WELCH, Peter John
    44 Hormead Road
    W9 3NQ London
    Administrateur
    44 Hormead Road
    W9 3NQ London
    EnglandBritish128987140001
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    British23098320003
    POLLOCK, Kieron John
    7 Stranks Close
    Highworth
    SN6 7DQ Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    7 Stranks Close
    Highworth
    SN6 7DQ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish93019400002
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187618040002
    SHAMEL, Mohsen
    Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8PA Solihull
    2
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Mill Lane
    Bentley Heath
    B93 8PA Solihull
    2
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish95982670004
    SPRAGG, James Forrester
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish127602840002
    TWEDDELL, Crispin Noel Stephen
    28 Leamington Road Villas
    W11 1HT London
    Administrateur
    28 Leamington Road Villas
    W11 1HT London
    EnglandBritish3687790001
    WALKER, Adrian Rowland
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish265227060001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    28 févr. 2018
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06326861
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour LASIG REALISATIONS 2 LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    28 févr. 201728 févr. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    LASIG REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2020
    Livré le 16 janv. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transactions
    • 16 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 23 août 2018
    En cours
    Brève description
    All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01 and including, amongst others, property at 12 seven dials, bath with title number ST148478 and trademarks numbered 2580856 and 3056836. for more details please refer to the supplemental debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transactions
    • 23 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 15 août 2018
    Livré le 21 août 2018
    En cours
    Brève description
    None at the date of the charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 21 août 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 05 févr. 2016
    Livré le 15 févr. 2016
    En cours
    Brève description
    The security document enclosed with this form MR01 includes a fixed charge or a fixed security over land and intellectual property, including unit E203/206, the arcadian centre, hurst street, birmingham B5 4TD. For more details of the land and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 15 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 nov. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2015
    Livré le 07 août 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 07 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 juil. 2015
    Livré le 28 juil. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Trademarks UK000025851, UK000023440 and UK000023428 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S Bank Trustees LTD in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 28 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 05 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 05 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of life policy
    Créé le 06 sept. 2011
    Livré le 09 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right to the policy and all money payable under the policy see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 31 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 août 2007
    Livré le 15 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 avr. 2007
    Livré le 12 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a ground floor and basement 7/8 mill lane cardiff.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 17 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property known as unit B1 chapel quarter nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as the courtyard 12 seven dials sawclose bath.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as unit 4, 38 monmouth street bath t/n ST150985.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 13-15 belvoir street leicester t/n LT356618.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property being 113 whiteladies road clifton bristol t/n BL63221.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 12 seven dials sawclose bath t/n ST148478.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 8-9 west one fitzwilliam street devonshire green sheffield t/n SYK470468.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as unit E203/206 arcadian centre hurst street birmingham t/n WM693264.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 17 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 7-8 mill lane cardiff.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 janv. 2004
    Livré le 03 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 30 sept. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 8 & 9 west one devonshire green shthe benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 20 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor 13-15 belvior street leicesthe benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 23 août 2002
    Livré le 28 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property piazza/courtyard area seven dials,bath. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 11 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 09069755 at 60-17-24 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or accounts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LASIG REALISATIONS 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 juil. 2020Administration started
    28 juin 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Daniel Imison
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0