BURDEROP INVESTMENTS LIMITED

BURDEROP INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBURDEROP INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02485284
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIPCOOL LIMITED26 mars 199026 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    14 pagesAA

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 28 août 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2020 au 30 sept. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Tejender Singh Chaudhary le 25 mars 2019

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Samuel James Hannis en tant que directeur le 19 juin 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Guy Douglas en tant qu'administrateur le 19 juin 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan R. Shattock en tant qu'administrateur le 03 juin 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian R Shelton en tant que directeur le 03 juin 2019

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Halcrow Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mars 2019

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Elms House 43 Brook Green London W6 7EF à Cottons Centre Cottons Lane London SE1 2QG le 26 mars 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Samuel James Hannis le 03 juil. 2017

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de James Christopher Rowntree en tant que directeur le 21 juin 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAUDHARY, Tejender Singh, Mr
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    185594040001
    DOUGLAS, Guy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    LOFTIN, Barbara Gillian
    18 Spinney Close
    KT3 5BQ New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    18 Spinney Close
    KT3 5BQ New Malden
    Surrey
    British2281770001
    MAIR, Kenneth
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    British545490002
    MAPPLEBECK, Rupert Neil
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Secrétaire
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    167746810001
    RHODES, Jeremy Dalton
    Fieldhead 1 & 2 Grafton Road
    Burbage
    SN8 3AP Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    Fieldhead 1 & 2 Grafton Road
    Burbage
    SN8 3AP Marlborough
    Wiltshire
    British3849330002
    ROBERTS, Geoffrey
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Secrétaire
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    172545850001
    CADWALLADER, Anthony Charles
    8 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Locksbottom
    Kent
    Administrateur
    8 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Locksbottom
    Kent
    British92090002
    COATES, Alasdair John Fraser
    Endeavour House
    Forder Way
    PE7 8GX Hampton
    Halcrow Group Ltd
    Peterborough
    United Kingdom
    Administrateur
    Endeavour House
    Forder Way
    PE7 8GX Hampton
    Halcrow Group Ltd
    Peterborough
    United Kingdom
    United KingdomBritish119145310001
    FLETCHER, Malcolm Stanley
    Whitley Lodge 21 Castle Street
    Aldbourne
    SN8 2DA Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Whitley Lodge 21 Castle Street
    Aldbourne
    SN8 2DA Marlborough
    Wiltshire
    British3133140001
    GAMMIE, Peter Geoffrey
    Alstone House
    243 Farleigh Road
    CR6 9EL Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    Alstone House
    243 Farleigh Road
    CR6 9EL Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish39597080002
    HANNIS, Samuel James, Mr
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Administrateur
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194337810003
    HARRINGTON, Sarah Elizabeth
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    England
    England
    Administrateur
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    England
    England
    United KingdomBritish172293460001
    HOLT, Neil
    Oakdale House
    Ampney Crucis
    GL7 5RZ Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Oakdale House
    Ampney Crucis
    GL7 5RZ Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish47847810001
    KENNEDY, Douglas Samuel
    Woodbury
    Green Lane, Prestwood
    HP16 0QE Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodbury
    Green Lane, Prestwood
    HP16 0QE Great Missenden
    Buckinghamshire
    British3190190002
    KERR, David John
    Fielding Road
    W4 1HP London
    11
    Administrateur
    Fielding Road
    W4 1HP London
    11
    EnglandBritish22568600002
    LLOYD, David Owen
    Kingsley
    The Mead
    GL7 2BB Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Kingsley
    The Mead
    GL7 2BB Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish3133150001
    MATHEWS, Steven Carrol
    South Jamaica Street
    80112 Englewood
    9191
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    South Jamaica Street
    80112 Englewood
    9191
    Colorado
    Usa
    UsAmerican173444500001
    ROWNTREE, James Christopher
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Administrateur
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    United KingdomBritish165022490001
    SHELTON, Brian R
    Brook Green
    W6 7EF London
    43
    England
    England
    Administrateur
    Brook Green
    W6 7EF London
    43
    England
    England
    United StatesAmerican178299300002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BURDEROP INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1674044
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BURDEROP INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2012
    Livré le 20 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including land, goodwill, debts, uncalled capital, fixtures, specified investments, all derivative rights, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • CH2M Hill Companies, LTD
    Transactions
    • 20 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2009
    Livré le 19 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or member of the group to the finance parties and from the company or any member of the group to any of the external ancillary lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 15 mars 2002
    Livré le 19 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Burderop park swindon thamesdown wiltshire t/no;-WT97758. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 août 2001
    Livré le 06 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 27 avr. 1993
    Livré le 15 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 30 oct. 1990
    Livré le 02 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a burderop park, swindon, wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0