NOVELFILE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNOVELFILE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02487826
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NOVELFILE LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe NOVELFILE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Oceanic Estates Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NOVELFILE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour NOVELFILE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 02 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    3 pagesAA

    État du capital au 09 juin 2016

    • Capital: GBP 50,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2016

    État du capital au 07 avr. 2016

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juil. 2015

    État du capital au 17 juil. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Nomination de Miss Ella Rose Smith en tant qu'administrateur le 06 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Amber Kristina Smith en tant que directeur le 06 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 avr. 2015

    État du capital au 17 avr. 2015

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 avr. 2014

    État du capital au 03 avr. 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Lawrence Edward Smith le 03 avr. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    4 pagesAA

    Nomination de Amber Kristina Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Fenella Punton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mars 2012

    4 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip John Hutchinson le 11 avr. 2012

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NOVELFILE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Lawrence Edward
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Secrétaire
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    British121647440001
    HUTCHINSON, Philip John
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Administrateur
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    EnglandBritish142746400001
    PUNTON, Fenella Lucy
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Administrateur
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    United KingdomBritish172387760001
    SMITH, Ella Rose
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Administrateur
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    EnglandBritish199469140001
    SMITH, Lawrence Edward
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Administrateur
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    EnglandBritish121647440001
    PRINCE, Hazel Valerie
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    British8759860001
    SMITH, Amber Kristina
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Administrateur
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    United KingdomBritish172387950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NOVELFILE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Gillian Lucy Hutchinson
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    Mrs Penelope Jane Smith
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Cracknore Hard
    Marchwood
    SO40 4ZD Southampton
    Oceanic Estates
    Hampshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    NOVELFILE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2002
    Livré le 15 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Methodist church, gosport street, lymington, hampshire, SO41 9BB. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 25 avr. 2001
    Livré le 27 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that leasehold land known as flat 18 river court gosport street lymington new forest hampshire title number HP369157. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 11 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 lulworth business centre nutwood way totton hampshire new forest - HP439243. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 août 1997
    Livré le 12 août 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit b rutherford road daneshill west industrial estate basingstoke t/no.HP167202 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 25 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 7 lulworth business park nutsey lane totton southampton hampshire the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1996
    Livré le 17 juil. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h property robinson house, winnall close, winnall, winchester, hampshire t/no. HP382304. And the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1995
    Livré le 23 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with clause 3 of the transfer of even date
    Brèves mentions
    The f/h land and buildings k/a the former telex exchange platform road southampton hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Bt Property Limited
    Transactions
    • 23 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1995
    Livré le 23 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a the former telex exchange platform road southampton hampshire and the present and future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 mars 1995
    Livré le 18 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 6 lulworth business centre nutsey lane toton hampshire t/n HP431786 the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 07 mars 1995
    Livré le 15 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 2 poundtree road southampton hampshire t/n HP473711 the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 mars 1995
    Livré le 15 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 4, 5, 8 and 9 lulworth business centre forming part of unit 14 westwood business park nutsey lane totton hampshire t/n HP359433 the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 mars 1995
    Livré le 15 mars 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 mars 1994
    Livré le 07 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to facility letters dated 3RD december 1992 and 20TH may 1993 and/or any other agreement
    Brèves mentions
    F/H land situate at london road city of southampton being numbers 43-47 london road southampton now k/a 43-49 london road southampton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 25 mai 1993
    Livré le 10 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 20/5/93
    Brèves mentions
    All rights title benefits & interests in the aggregate of all rents service charge damages interest lump sums & other capital or income sums accruing & paid to or for the benefit or account of the assignor under any of the leases underleases and/or tenancies may now be subject or granted. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 10 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 mai 1993
    Livré le 10 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 20/5/93
    Brèves mentions
    F/H property k/a land & buildings on the south side of fitzherbert road farlington industrial estate farlington portsmouth t/no HP184080 & f/h land k/a unit e empress park 179 empress road bevois valley southampton t/no HP304750. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 10 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge of rental income
    Créé le 22 janv. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter dated 3/12/92 or otherwise
    Brèves mentions
    All the rights titles and benefits and interests of the assignor present and future in the aggregate of all rents payable to the assignor under any of the leases unerleases or tenancies of salisbury house salisbury road southampton and other properties (see form 395 M327C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letters dated 3/12/92 and/or any other agreement and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a salisbury house ,salisbury road totton southampton t/n HP383747 and all that f/h property k/a 41/53 gosport street and 9/17 waterloo road lymingtron hampshire forming part of the title t/n HP425211. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on cash deposit
    Créé le 22 janv. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum or sums which are from time to time standing to the credit of the depositor on account number 72425703 with the bank at the moneycentre plymouth PL11SE.
    Personnes ayant droit
    • Western Trust & Savings Limited
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 oct. 1992
    Livré le 31 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    41-53 gosprt street and 9-17 waterloo road lymington hampshire t/n HP425211. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1992
    Livré le 12 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0