ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED

ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02490368
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERIDIEN HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED16 janv. 200416 janv. 2004
    THE VICTORIA AND ALBERT HOTEL COMPANY LIMITED30 avr. 199030 avr. 1990
    FLEETNESS 118 LIMITED09 avr. 199009 avr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 juil. 2013

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 févr. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 févr. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 févr. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 févr. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2009

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 févr. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 01 août 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Divers

    O/C - removal of liquidator
    10 pagesMISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Statuts

    15 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed meridien hotels & resorts compan y LIMITED\certificate issued on 03/01/06
    2 pagesCERTNM

    Qui sont les dirigeants de ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MERIDIEN SECRETARIES LIMITED
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HT London
    Secrétaire
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HT London
    98359920002
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Administrateur
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director87347070001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    BritishDirector39862810001
    LORD, Vernon James
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    Secrétaire
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    BritishDirector64957780001
    LUCK, Stuart Richard
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    British63728750001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Secrétaire
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishDirector78059700001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    BritishCompany Secretary37564540001
    CAU, Antoine Edmond Andre
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    Administrateur
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    FrenchChief Executive59395250002
    DAVENPORT, Donald Andrew
    Ramsbury House 23 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Ramsbury House 23 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishDirector13178710003
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Administrateur
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritishDirector Of Development55689440001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant10297860001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Administrateur
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    BritishFinance Director39862810001
    LAMBERT, Bernard Charles Hector
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    Administrateur
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    AustriaFrenchManaging Director60956020002
    LORD, Vernon James
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    Administrateur
    Malmesbury House
    New Pale Road
    WA14 3HG Manley
    Cheshire
    BritishDirector64957780001
    LUCK, Stuart Richard
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    19 Lime Close
    Bromham
    MK43 8HD Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Director63728750001
    MACGREGOR, Alan Morrison
    51 Westgate
    WA15 9BA Hale
    Cheshire
    Administrateur
    51 Westgate
    WA15 9BA Hale
    Cheshire
    BritishSales Marketing Director90880420001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Administrateur
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishDirector78059700001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Administrateur
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishInternational Tax Manager78059700001
    MAHONEY, Richard Lee
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Administrateur
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    AmericanChief Operating Officer78240440004
    MALONEY, David Ossian
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer69071800002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    BritishFinance Director47770480002
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Administrateur
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    BritishCompany Director6741720003
    RILEY, Robert Earl
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    Administrateur
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    United States CitizenChief Executive Officer95184480002
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCompany Secretary37564540001
    WILLIAMS, John Owen
    3 Wolsey Drive
    Bowden
    WA14 3QU Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    3 Wolsey Drive
    Bowden
    WA14 3QU Altrincham
    Cheshire
    BritishManaging Director12556640002

    ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Limited recourse charge over lm opco debts
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 10 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of security assignment including all rights of enforcement of the same: all right title and interest in the lm opco debts and the proceeds account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 10 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental debenture
    Créé le 10 sept. 2001
    Livré le 13 sept. 2001
    En cours
    Montant garanti
    Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC ("the Security Agent") as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Creditors
    Transactions
    • 13 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 juil. 2001
    Livré le 31 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or the borrowers (as defined) to the beneficiaries (as defined) under the facility agreement and all vat facility liabilities owing from the vat facility borrowers (as defined) to the vat facility beneficiaries (as defined) under the grosvenor facility agreement and the waldorf facility agreement (both terms as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the proceeds account,as defined,and all rights of enforcement and all other rights title and interest in the inducement payment,as defined; see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Maintenance fund deed
    Créé le 11 juil. 2001
    Livré le 31 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the company's liability in maintaining the premises (as defined) and due from the company to the chargee under clauses 3.5,3.6 and 3.7 of the lease dated 11 july 2001 (as defined)
    Brèves mentions
    The company's interest in an interest bearing account maintained at a bank in which to hold the maintenance fund.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Hotel Investments No 3 Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors
    Créé le 11 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)

    ZOE HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 nov. 2013Dissolved on
    02 févr. 2006Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Heath Sinclair
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Christopher J Hughes
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0