DUNBIA (WALES)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNBIA (WALES)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 02490902
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNBIA (WALES) ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe DUNBIA (WALES) ?

    Adresse du siège social
    Dunbia Wales Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Carmarthenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNBIA (WALES) ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNBIA (WALES) LIMITED05 juil. 200605 juil. 2006
    ORIEL JONES & SON LIMITED29 juil. 199129 juil. 1991
    WEBBERS HATHERLEIGH LIMITED12 sept. 199012 sept. 1990
    SHANNON COURT (49) LIMITED09 avr. 199009 avr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de DUNBIA (WALES) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNBIA (WALES) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01
    XA0BEZL6

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01
    X9CPCGSG

    Inscription de la charge 024909020018, créée le 29 juil. 2020

    75 pagesMR01
    X9B8H5A1

    Cessation de la nomination de Matthew Samuel Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01
    A9AMFA1C

    Cessation de la nomination de James George Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01
    A9AMFA1K

    Inscription de la charge 024909020017, créée le 29 juil. 2020

    43 pagesMR01
    X9B5V4UY

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X8X10EAX

    Notification de Dunbia (Uk) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    4 pagesPSC02
    A8KNR0PL

    legacy

    2 pagesSH20
    R8K1BVA1

    État du capital au 13 déc. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19
    A8K0JVU2

    legacy

    2 pagesCAP-SS
    R8K1BV9T

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancelling and extinguishing all but one of the issued shares of £1.00 each in the company 29/11/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de Dunbia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    3 pagesPSC07
    A8JY0XLF

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2018

    30 pagesAA
    A8ETJ3GG

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X82LGW2O

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    28 pagesAA
    A7EZJYUI

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X739MWM0

    Cessation de la nomination de Sean Breen en tant que secrétaire le 27 févr. 2018

    1 pagesTM02
    X70NWPT6

    Comptes annuels établis au 02 avr. 2017

    27 pagesAA
    A6LN53WR

    Inscription de la charge 024909020016, créée le 18 déc. 2017

    25 pagesMR01
    A6LVCUEO

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Queally le 23 nov. 2017

    2 pagesCH01
    X6JSJKI0

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Niall Browne le 23 nov. 2017

    2 pagesCH01
    X6JSJGO9

    Qui sont les dirigeants de DUNBIA (WALES) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone223137440001
    QUEALLY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239899450002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Secrétaire
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239274700001
    DOBSON, James George
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Secrétaire
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    British60391230001
    JONES, John Barrie Prosser
    Llys Teifi
    Cwmann
    SA48 8JN Lampeter
    Dyfed
    Secrétaire
    Llys Teifi
    Cwmann
    SA48 8JN Lampeter
    Dyfed
    British8043470004
    POPE, Leyton G
    4 Stone Court
    Masons Square
    SA45 9SF Newquay
    Ceredigion
    Secrétaire
    4 Stone Court
    Masons Square
    SA45 9SF Newquay
    Ceredigion
    BritishAccountant58117010001
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    United KingdomBritishCo Director130963600004
    DOBSON, James George
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Northern IrelandBritishDirector60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    United KingdomBritishManaging Director216974160001
    DOBSON, Robert John
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Northern IrelandBritishDirector60768390001
    EDWARDS, Paul John Delme
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    WalesBritishDirector101449890001
    EDWARDS, Paul John Delme
    Glynview
    SA48 8EL Cwmann
    Dyfed
    Administrateur
    Glynview
    SA48 8EL Cwmann
    Dyfed
    WalesBritishOperations Director101449890001
    JONES, John Lewis
    Y Dolau
    Felinfach
    SA48 8AE Lampeter
    Ceredigion
    Administrateur
    Y Dolau
    Felinfach
    SA48 8AE Lampeter
    Ceredigion
    United KingdomBritishManager46199030002
    JONES, John Emrys Oriel
    Mackwith Castle
    Llanfihangel Ar Arth
    SA39 9LB Pencader
    Dyfed
    Administrateur
    Mackwith Castle
    Llanfihangel Ar Arth
    SA39 9LB Pencader
    Dyfed
    BritishChairman48824610001
    JONES, John Barrie Prosser
    Llys Teifi
    Cwmann
    SA48 8JN Lampeter
    Dyfed
    Administrateur
    Llys Teifi
    Cwmann
    SA48 8JN Lampeter
    Dyfed
    BritishChief Executive8043470004
    NICHOLSON, David John
    Beechwood
    Ffosyffin
    SA46 0HD Aberaeron
    Dyfed
    Administrateur
    Beechwood
    Ffosyffin
    SA46 0HD Aberaeron
    Dyfed
    BritishManaging Director63921570001
    POPE, Leyton G
    4 Stone Court
    Masons Square
    SA45 9SF Newquay
    Ceredigion
    Administrateur
    4 Stone Court
    Masons Square
    SA45 9SF Newquay
    Ceredigion
    BritishFinance Director58117010001
    POTTS, Colin Edwin
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Administrateur
    Teify Park
    Lampeter Road
    SA40 9QE Llanybydder
    Dunbia Wales
    Carmarthenshire
    Wales
    Northern IrelandBritishCompany Director125726160003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUNBIA (WALES) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    29 nov. 2019
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    Non
    Forme juridiqueUnlimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03382084
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementNorthern Ireland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies Register
    Numéro d'enregistrementNi059523
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DUNBIA (WALES) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2020
    Livré le 11 août 2020
    En cours
    Brève description
    The lands and premises situate at and known as duar villa and abattoir being land and buildings known as teify park, lampeter road, llanybydder and registered with freehold title numbers WA656465 and CYM41151 together with the various parcels of land registered with freehold title numbers WA638140, WA899705, WA856769, CYM18006, CYM72907, shares and insurances as per the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2020
    Livré le 10 août 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 déc. 2017
    Livré le 23 déc. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 23 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 27 oct. 2017
    En cours
    Brève description
    Duar villa and abattoir k/a teify park lampeter road llanybydder please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 27 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 19 oct. 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 19 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 juil. 2014
    Livré le 05 août 2014
    En cours
    Brève description
    Teify park, lampeter road, llanybydder comprised in title numbers WA656465 and CYM41151.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 05 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2014
    Livré le 12 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Teify park, lampeter road, llanybydder comprised in title number WA656465 and title number CYM41151 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 2011
    Livré le 23 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 23 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 oct. 2010
    Livré le 03 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 03 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 oct. 2010
    Livré le 18 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First equitable charge all purchased debts bring any book debts,all other debts and all associated rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 nov. 2008
    Livré le 08 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the south side of lampeter road llanybydder t/no WA856769, hafan deg lampeter road llanybydder t/no WA638140, smithfield house llanybydder t/no CYM72907 (for further details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • James George Dobson, Robert John Dobson and Premier Pension Trustees Limited
    Transactions
    • 08 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 13 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Caerfagu abattoir nantmel llandridod wells.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 13 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 13 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Duar villa and abattoir teifi park lampeter road llanybydder together with land adjoining.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 13 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 05 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 05 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over all book debts
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 05 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the bank.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 05 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 juil. 1998
    Livré le 10 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or oriel jones & son (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a caerfagu abattoir nantmel llandrindod wells powys t/no wa 839037.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1992
    Livré le 04 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Teify park abattoir dyfed llanybydder dyfed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 oct. 1991
    Livré le 16 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details) ref: M333C.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0