ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED

ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02491309
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    • (4525) /
    • (7011) /

    Où se situe ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FROGLAND SERVICES LIMITED10 avr. 199010 avr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2009

    3 pagesAA

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    6 pagesSH10

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 janv. 2010

    État du capital au 20 janv. 2010

    • Capital: GBP 260,900
    SH01

    Comptes établis au 31 juil. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 juil. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    11 pages288a

    legacy

    11 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2005

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2004

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2003

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Secrétaire
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish24075160004
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    FORSTER, Garry James
    Huggins Cottage
    Back Lane
    GU4 7SD East Clandon
    Surrey
    Secrétaire
    Huggins Cottage
    Back Lane
    GU4 7SD East Clandon
    Surrey
    British38750850001
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Secrétaire
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    British83397580001
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Secrétaire
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010
    BARR, James Walter
    10 Broughton Crescent
    Barlaston
    ST12 9DB Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    10 Broughton Crescent
    Barlaston
    ST12 9DB Stoke On Trent
    Staffordshire
    British55617100002
    CAWDRON, James Edward
    31 Lawn Avenue
    Etwall
    DE65 6JB Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    31 Lawn Avenue
    Etwall
    DE65 6JB Derby
    Derbyshire
    British262050002
    CONNOLLY, Peter James
    147 Church Lane
    Selston
    NG16 6FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    147 Church Lane
    Selston
    NG16 6FB Nottingham
    Nottinghamshire
    British55292290001
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Administrateur
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    EnglandBritish38750850004
    FOWLER, Ian Robert
    St. Enodoc
    The Green, Upper Poppleton
    YO26 6DF York
    North Yorkshire
    Administrateur
    St. Enodoc
    The Green, Upper Poppleton
    YO26 6DF York
    North Yorkshire
    British67228970001
    ORANGE, Thomas Gordon
    Foxhill Cottage
    Weetwood Lane
    LS16 5PY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Foxhill Cottage
    Weetwood Lane
    LS16 5PY Leeds
    West Yorkshire
    British2236390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010

    ILKLEY & PETERBOROUGH PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings at station plaza ilkley county of west yorkshire with all rental income & monetry debts & claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays De Zoete Wedd Limited in Its Capacity as Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental loan agreement
    Créé le 23 sept. 1994
    Livré le 07 oct. 1994
    En cours
    Montant garanti
    The amounts referred to in an agreement dated 28TH june 1994 in accordance with the terms of the supplemental loan agreement
    Brèves mentions
    All asset property & undertaking.
    Personnes ayant droit
    • J F Miller Properties Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 20 juil. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and/or this debenture and/or any other security documents
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over all undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (see form 395 ref M470C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays De Zoete Weddas Trustee for Itself & the Beneficiries
    Transactions
    • 20 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 04 juil. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28 june 1990 and/or this charge
    Brèves mentions
    F/H property and buildings comprising 0.739 of an acre situate at staniland way, werrington, peterborough k/as sundance house and l/h property and buildings situate at station rd, brook street and railway rd, ilkley, W. yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Thomas G Orange
    • Ian R Fowler
    • Ebs Pensioneer Trustees Limited
    Transactions
    • 04 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 29 juin 1990
    Livré le 04 juil. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 28 june 1990 and/or this charge
    Brèves mentions
    F/H property and buildings comprising 0.739 of an acre situate at staniland way, werrington, peterborough k/a sundance house and l/h property and buildings situate at station rd brook street and railway rd, ilkley, w yorkshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • J.F. Miller Properties
    Transactions
    • 04 juil. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0