FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED

FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02494234
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    • Agriculture mixte (01500) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mary Street House
    Mary Street
    TA1 3NW Taunton
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HORIZON KENT LIMITED08 juil. 199108 juil. 1991
    HORRELL KENT LIMITED24 mai 199024 mai 1990
    MARKSEAL LIMITED20 avr. 199020 avr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 oct. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:resolution re: liquidators authority
    1 pagesLIQ MISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 juin 2017

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 01 oct. 2016

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Stonegate Holdings Ltd the Old Sidings Corsham Road Lacock Chippenham Wiltshire SN15 2LZ à Mary Street House Mary Street Taunton TA1 3NW le 21 juin 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James David Sheppard en tant que directeur le 19 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James David Sheppard en tant que secrétaire le 19 juin 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 024942340015 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 024942340014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 024942340013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    8 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    7 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 024942340016 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 03 oct. 2015

    6 pagesAA

    Inscription de la charge 024942340016, créée le 18 avr. 2016

    35 pagesMR01

    Inscription de la charge 024942340015, créée le 18 avr. 2016

    10 pagesMR01

    Nomination de Mr Adrian David Gott en tant qu'administrateur le 18 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mars 2016

    État du capital au 11 mars 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 27 sept. 2014

    6 pagesAA

    Inscription de la charge 024942340014, créée le 30 mai 2015

    43 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GOTT, Adrian David
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Nether Kellet
    LA6 1DZ Carnforth
    Addington Lodge
    Lancashire
    England
    United KingdomBritish111647120004
    COLEY, Susan Gaynor
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    Secrétaire
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    British60532170001
    ELLIOTT, Julian Christopher
    3 Boconnoc Avenue
    PL17 7TN Callington
    Cornwall
    Secrétaire
    3 Boconnoc Avenue
    PL17 7TN Callington
    Cornwall
    British104229500001
    KENT, Michael Richard John
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    Secrétaire
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    British11373130002
    ROGERS, Nicholas Ian
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    Secrétaire
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    British42807600002
    SHEPPARD, James David
    c/o Stonegate Holdings Ltd
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    Wiltshire
    England
    Secrétaire
    c/o Stonegate Holdings Ltd
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    Wiltshire
    England
    147725800001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    Secrétaire
    Island Cottage
    RG14 5HT West Mills
    Berkshire
    British104835460001
    SWAFFIELD, Roger Leslie
    West Mills
    RG14 5HT Newbury
    Island Cottage
    Berkshire
    Secrétaire
    West Mills
    RG14 5HT Newbury
    Island Cottage
    Berkshire
    British133684550001
    BALLANTYNE, Andrew Joseph, Dr
    9 Treverbyn Close
    PL14 3TG Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    9 Treverbyn Close
    PL14 3TG Liskeard
    Cornwall
    British11576400001
    COLEY, Susan Gaynor
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    Administrateur
    Little Idless
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Cornwall
    British60532170001
    CORBETT, Pamela Jane
    Marston House
    Yarlet Lane, Marston
    ST18 9ST Stafford
    Administrateur
    Marston House
    Yarlet Lane, Marston
    ST18 9ST Stafford
    EnglandBritish123694150001
    KENT, Joseph Edward Clifford
    Goldenbank Lodge Plymouth Road
    PL14 3PB Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Goldenbank Lodge Plymouth Road
    PL14 3PB Liskeard
    Cornwall
    British11373150001
    KENT, Michael Richard John
    The Old Rectory
    Braddock Lostwithiel
    PL22 0RN Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    The Old Rectory
    Braddock Lostwithiel
    PL22 0RN Liskeard
    Cornwall
    British67069980002
    KENT, Michael Richard John
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Copperwood
    Old Road
    PL14 6DY Liskeard
    Cornwall
    British11373130002
    LAPTHORNE, Nigel Alan
    1 Penhale Meadow
    St Cleer
    PL14 5RR Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    1 Penhale Meadow
    St Cleer
    PL14 5RR Liskeard
    Cornwall
    British54387590001
    ROGERS, Nicholas Ian
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    16 Rapson Road
    PL14 3NX Liskeard
    Cornwall
    British42807600003
    ROGERS, Nicholas Ian
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Tremerryn
    Lake Lane
    PL14 3DE Liskeard
    Cornwall
    British42807600002
    SHEPPARD, James David
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Gorse Cottage
    New Lydd Road, Camber
    TN31 7QS Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish123411450001
    VIGUS, Barry John
    Trevesson
    Old Road
    PL14 6DW Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Trevesson
    Old Road
    PL14 6DW Liskeard
    Cornwall
    British69757520003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Clarence Court Eggs Limited
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    06 avr. 2016
    Corsham Road
    Lacock
    SN15 2LZ Chippenham
    The Old Sidings
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement01019356
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 avr. 2016
    Livré le 28 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pamela Jane Corbett
    • Richard Gerard Heaton Corbett
    Transactions
    • 28 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 avr. 2016
    Livré le 21 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transactions
    • 21 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2015
    Livré le 04 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    No land, ships, aircraft or intellectual property.. Please see charge document for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transactions
    • 04 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2015
    Livré le 03 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Each company with full title guarantee hereby charges its credit balances to the bank to secure repayment of the secured obligations.. Please see charge document for more details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (No. 2065)
    Transactions
    • 03 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 25 juil. 2008
    Livré le 29 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Créé le 25 juil. 2008
    Livré le 29 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2008
    Livré le 29 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 23 juin 2006
    Livré le 05 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property and all buildings and fixtures from time to time thereon known as trenouth farm st ervan wadebridge cornwall t/n CL168841.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 16 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 05 mars 2008
    All assets debenture
    Créé le 23 juin 2006
    Livré le 05 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any appointee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 02 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Trenouth farm st ervan wadebridge cornwall t/n CL168841,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 05 mars 2008
    • 06 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 oct. 2004
    Livré le 28 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2F/h property k/a trenouth farm, st ervan, wadebridge t/no. CL168841. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 août 2004
    Livré le 07 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 févr. 2001
    Livré le 16 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H trenouth farm st. Ervan wadebridge cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 06 mai 1997
    Livré le 21 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 avr. 1993
    Livré le 11 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 16 août 1990
    Livré le 03 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company see form 395 (ref 370) for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FARMHOUSE FREEDOM EGGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 oct. 2018Dissolved on
    30 juin 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laurence George Russell
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset
    practitioner
    Albert Goodman
    Mary Street House
    TA1 3NW Mary Street
    Taunton Somerset

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0