HOZELOCK GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOZELOCK GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02496708
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits en plastique (22290) / Industries manufacturières

    Où se situe HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLYVILLE LIMITED27 avr. 199027 avr. 1990

    Quels sont les derniers comptes de HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Yves Emile Pierre Belegaud en tant qu'administrateur le 17 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de Guerric Ballu en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 déc. 2019

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Guerric Ballu en tant que directeur le 17 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2017

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Emmanuel Julien Perrousset en tant que secrétaire le 30 nov. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gary Thorington Jones en tant que secrétaire le 30 nov. 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2016

    État du capital au 18 mai 2016

    • Capital: GBP 1,227,636.45
    SH01

    Nomination de Mr Gary Thorington Jones en tant que secrétaire le 24 mars 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Helen Semmens en tant que secrétaire le 23 mars 2016

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2016 au 30 sept. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 août 2015

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Helen Semmens en tant que secrétaire le 01 août 2015

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 août 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2015

    État du capital au 18 mai 2015

    • Capital: GBP 1,227,636.45
    SH01

    Qui sont les dirigeants de HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PERROUSSET, Emmanuel Julien
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Secrétaire
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    240709370001
    BALLU, Marc
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Administrateur
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    United KingdomFrench174120160002
    BELEGAUD, Yves Emile Pierre
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Administrateur
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    FranceFrench265689980001
    JONES, Gary Thorington
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Secrétaire
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    207074230001
    POTTER, Donald Stanley
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British14077190001
    SEMMENS, Helen
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Secrétaire
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    199904670001
    WOOD, Martin
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Secrétaire
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    153428180001
    ADAMS, Peter George
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    Administrateur
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    British112143030001
    ALGAR, David Stanley
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Administrateur
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    EnglandBritish104137450004
    BALLU, Guerric
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Administrateur
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    FranceFrench80574650002
    CODLING, David Fletcher
    Bowers Farm
    Magpie Lane
    HP7 0LU Coleshill Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bowers Farm
    Magpie Lane
    HP7 0LU Coleshill Amersham
    Buckinghamshire
    British14064770002
    DUDEK, Michael Henry
    Walnut Tree Cottage Walton Lane
    Wellesbourne
    CV35 9RD Warwickshire
    Administrateur
    Walnut Tree Cottage Walton Lane
    Wellesbourne
    CV35 9RD Warwickshire
    British39236340002
    FEWELL, Peter William Charles
    Mount Pleasant Farm
    Thame Road
    OX44 7HX Great Milton
    Oxon
    Administrateur
    Mount Pleasant Farm
    Thame Road
    OX44 7HX Great Milton
    Oxon
    British14037250003
    FLEURAT, Pierre
    9 Avenue Elisee Reclus
    FOREIGN 75007
    Paris
    France
    Administrateur
    9 Avenue Elisee Reclus
    FOREIGN 75007
    Paris
    France
    French72217940002
    FOBEL, Anthony Peter
    1st Floor Flat 105 King Henrys Road
    NW3 3QX London
    Administrateur
    1st Floor Flat 105 King Henrys Road
    NW3 3QX London
    British71917500001
    HALL, Stephen John
    Adringal Cottages
    Horton Horton Hill
    BS37 6QP Bristol
    1
    Administrateur
    Adringal Cottages
    Horton Horton Hill
    BS37 6QP Bristol
    1
    EnglandBritish147526740001
    HARGREAVES, David
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    British54809160001
    HART, Raymond John
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    British63042500002
    MACKENZIE, Alexander Donald
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish105120270001
    MASKELL, Philip John
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    Administrateur
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    British5733160002
    POTTER, Donald Stanley
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish14077190001
    ROLLAND, Stuart Stacy
    Rosemary Cottage
    Northchurch
    HP4 3QS Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Rosemary Cottage
    Northchurch
    HP4 3QS Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish206839450001
    RUSH, Peter John
    2 The Conifers
    Birches Lane
    CV8 2BF Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    2 The Conifers
    Birches Lane
    CV8 2BF Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritish94039640002
    SNOWDEN, Paul Boothby
    10 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    Birmingham
    Administrateur
    10 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    Birmingham
    British69874210002
    WALKER, Gerald Neill
    The Laurels 5 Aston Gardens
    Aston Rowant
    OX49 5SY Watlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Laurels 5 Aston Gardens
    Aston Rowant
    OX49 5SY Watlington
    Oxfordshire
    British84568760001
    WOOD, Martin Richard
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Administrateur
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    EnglandBritish152495780001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOZELOCK GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Guerric Ballu
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    06 avr. 2016
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Oui
    Nationalité: French
    Pays de résidence: France
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Marc Ballu
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    06 avr. 2016
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    Non
    Nationalité: French
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    HOZELOCK GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 mars 2010
    Livré le 24 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 16 janv. 2009
    Livré le 17 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee and debenture
    Créé le 29 juil. 1999
    Livré le 12 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    Transactions
    • 12 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture and guarantee
    Créé le 30 juin 1993
    Livré le 07 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 25TH april 1990 (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Lenders
    Transactions
    • 07 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture & guarantee.
    Créé le 17 juil. 1990
    Livré le 06 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein on the chargee under the terms of the facilities agreement dated 17/7/90 and this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent
    Transactions
    • 06 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0