FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02501089 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Griffins Tavistock House South WC1H 9LG Tavistock Square London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 18 pages | LIQ13 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Triton Square Regent's Place London NW1 3AN à Griffins Tavistock House South Tavistock Square London WC1H 9LG le 19 nov. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher James Wise en tant qu'administrateur le 16 avr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Roland Honey en tant que directeur le 15 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Rachel Jane Morrison le 17 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Notification de Santander Equity Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 juin 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Santander Uk Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 juin 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Roland Honey le 14 mai 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jason Leslie Wright en tant que directeur le 28 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Jason Leslie Wright en tant qu'administrateur le 14 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Rachel Jane Morrison en tant qu'administrateur le 14 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michelle Anne Hill en tant que directeur le 18 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom |
| 171739990001 | ||||||||||
| MORRISON, Rachel Jane | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 79351960007 | |||||||||
| WISE, Christopher James | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 13794010007 | |||||||||
| BARNES, John Charlton | Secrétaire | Pinehurst Felcourt Road Felcourt RH19 2LA East Grinstead West Sussex | British | 2951340001 | ||||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Secrétaire | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
| EVANS, Margaret Janet | Secrétaire | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London Abbey National House | 133893020001 | |||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| BRIAN, Michael | Administrateur | 30 Highlands Road KT22 8NJ Leatherhead Surrey | British | 24633390001 | ||||||||||
| CARTE, Brian Addison | Administrateur | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 145559220001 | |||||||||
| CARTE, Brian Addison | Administrateur | Fairfield Lodge Hardwick Close Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 145559220001 | |||||||||
| COLES, Shaun Patrick | Administrateur | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 95706540002 | |||||||||
| FINNERTY, Colin William | Administrateur | Sayers House Sayers Common BN6 9HU Hassocks West Sussex | British | 52209790001 | ||||||||||
| GREEN, David Martin | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 157202700001 | |||||||||
| HILL, Michelle Anne | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 185425510001 | |||||||||
| HILL, Victor Thomas | Administrateur | 16 Draxmont Way Surrenden Road BN1 6QF Brighton East Sussex | England | British | 82403860001 | |||||||||
| HONEY, Andrew Roland | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 151306350001 | |||||||||
| HORLOCK, Keith William | Administrateur | Overways 2 Aston Park Off London Road HP22 5HL Aston Clinton Buckinghamshire | England | British | 7212390002 | |||||||||
| LEWIS, Derek John | Administrateur | B01 Santander Uk Plc 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London Secretariat Ts6 United Kingdom | England | British | 34423910002 | |||||||||
| LINSLEY, Scott | Administrateur | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 126009060001 | |||||||||
| LUCKEN, Glen | Administrateur | 18 The Cloisters MK45 2UJ Ampthill Bedfordshire | England | British | 81760160001 | |||||||||
| PETRIE, Jessica Frances | Administrateur | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 165585400001 | |||||||||
| PURDY, John Douglas | Administrateur | Kendals Little Heath Lane, Potten End HP4 2RY Berkhamsted Hertfordshire | British | 68943220001 | ||||||||||
| ROBERTS, Diane Elisabeth | Administrateur | 2 Woodside Close CR3 6AU Caterham Surrey | England | British | 88738670001 | |||||||||
| SAMUEL, Martin | Administrateur | 25 Great Lime Kilns Southwater RH13 9JL Horsham West Sussex | British | 81095180001 | ||||||||||
| SCOTT, John Stearn | Administrateur | Three Elms Common Gate Road WD3 5JR Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 7126810001 | |||||||||
| SMART, James Ramsay | Administrateur | 13 Alexandra Drive MK16 0ES Newport Pagnell Buckinghamshire | British | 57425040001 | ||||||||||
| WRIGHT, Jason Leslie | Administrateur | Aldworth Road Compton RG20 6RD Berkshire Hillfoot Farm United Kingdom | United Kingdom | British | 273396180001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Equity Investments Limited | 28 juin 2018 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Santander Uk Plc | 06 avr. 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
FIRST NATIONAL MOTOR FACILITIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0