EMAP INSIGHT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | EMAP INSIGHT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02502812 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EMAP INSIGHT LIMITED ?
Adresse du siège social | Greater London House Hampstead Road NW1 7EJ London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EMAP INSIGHT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour EMAP INSIGHT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emily Henrietta Gestetner en tant que directeur le 29 juin 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de John Keith Gulliver en tant qu'administrateur le 11 juin 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Duncan Anthony Painter le 02 avr. 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Duncan Anthony Painter en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martyn John Hindley en tant que directeur le 22 déc. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Taylor en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 30 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martyn John Hindley le 30 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Shanny Looi le 01 mars 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Martyn John Hindley le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Emily Henrietta Gestetner le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Nigel John Taylor le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Helen Frances Hay en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Helen Frances Hay en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EMAP INSIGHT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOI, Shanny | Secrétaire | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | British | 129906110001 | ||||||
GULLIVER, John Keith | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | United Kingdom | British | Company Director | 170112360001 | ||||
PAINTER, Duncan Anthony | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | England | British | Company Director | 132649960001 | ||||
ANDERS, Philip William | Secrétaire | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | Director | 42645630003 | |||||
ELSDON, Kate | Secrétaire | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | Company Secretary | 107227940002 | |||||
GILES, Nicholas David Martin | Secrétaire | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
HAY, Helen Frances | Secrétaire | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146425680001 | |||||||
HENSON, Mark Richard | Secrétaire | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
HOGG, Marianne Lisa | Secrétaire | 43b Norroy Road Putney SW15 1PQ London | British | Solicitor | 101383970001 | |||||
LEES, Barbara | Secrétaire | Milford Street CB1 2LP Cambridge 15a Cambridgeshire | Other | 79614280001 | ||||||
NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Secrétaire | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | Company Secretary | 120147010002 | |||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
WHITEHEAD, Christine | Secrétaire | Cut Heath House Parsonage Lane SL2 3PA Farnham Common Buckinghamshire | British | Director | 3277810003 | |||||
ANDERS, Philip William | Administrateur | 5 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | England | British | Chartered Accountant | 42645630003 | ||||
BHAKTA-JONES, Nilema | Administrateur | 7b Wolseley Road N8 8RR London | United Kingdom | British | Lawyer | 124888590001 | ||||
COLE, Christopher Michael | Administrateur | Lucas Avenue HA2 9JU Harrow 30 Middlesex England | United Kingdom | British | Accountant | 133510510001 | ||||
ELSDON, Kate | Administrateur | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | Company Secretary | 107227940002 | |||||
FOLLAND, Nicholas James | Administrateur | Strethall House Strethall CB11 4XJ Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Group Legal Director | 73711450003 | ||||
GESTETNER, Emily Henrietta | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | United Kingdom | British | Accountant | 138386390001 | ||||
GILES, Nicholas David Martin | Administrateur | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | Company Secretary | 85529870001 | |||||
HENSON, Mark Richard | Administrateur | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 104630800001 | ||||
HINDLEY, Martyn John | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | England | British | Finance Director | 134332760002 | ||||
HOGG, Marianne Lisa | Administrateur | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | Solicitor | 101383970002 | |||||
LAVELLI, John Stephen | Administrateur | 2 Nathans Close AL6 9QB Welwyn Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 56438160001 | |||||
MOLONEY, Thomas Charles | Administrateur | 20 Queen Elizabeths Walk N16 0HX London | United Kingdom | British | Publisher | 15672060004 | ||||
NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Administrateur | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | Company Secretary | 120147010002 | |||||
PHILLIPS, Alison Barbara | Administrateur | The Gatehouse 1 Rhymers Gate Wyton PE17 2JR Huntingdon | Uk | British | Tax Manager | 61837750001 | ||||
TAYLOR, Christopher Nigel John | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House | British | Company Director | 130943020001 | |||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Administrateur | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | England | British | Company Secretary | 135181230001 | ||||
WHITEHEAD, Christine | Administrateur | Cut Heath House Parsonage Lane SL2 3PA Farnham Common Buckinghamshire | British | Director | 3277810003 | |||||
WHITEHOUSE, Thomas Richard | Administrateur | Cut Heath House Parsonage Lane Farnham Common SL2 3PA Slough Buckinghamshire | British | Company Director | 58982570001 |
EMAP INSIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit agreement | Créé le 19 déc. 1994 Livré le 06 janv. 1995 | En cours | Montant garanti The payment of the rents and other sums reserved by and the performance and observance of the company's obligations to the lessor in the underlease of even date | |
Brèves mentions The credit balance on the company's deposit account at midland bank PLC at 2 craven road paddington london W2 including all monies paid into the account in accordance with the agreement dated 19 december 1994. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 18 juin 1991 Livré le 24 juin 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0