MNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMNE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02503995
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MNE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MNE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DESIGNJOB LIMITED21 mai 199021 mai 1990

    Quels sont les derniers comptes de MNE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MNE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de John Gornall en tant que secrétaire le 30 juin 2014

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul Martin Hopkinson en tant que directeur le 30 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Claire Louise Craigie en tant que secrétaire le 30 juin 2014

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr John Gornall en tant qu'administrateur le 30 juin 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2014

    État du capital au 11 juin 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Ian John Hares en tant qu'administrateur le 25 nov. 2013

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Phillip Alexander Mclelland en tant que directeur le 25 nov. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2013 au 31 mars 2014

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr John Gornall en tant que secrétaire le 03 déc. 2012

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de MNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRAIGIE, Claire Louise
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Uk Asset Resolution Limited
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Uk Asset Resolution Limited
    West Yorkshire
    England
    190359110001
    GORNALL, John
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Croft Road, Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish41289370001
    HARES, Ian John
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Ukar
    West Yorkshire
    Administrateur
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Ukar
    West Yorkshire
    United KingdomBritish55792230001
    BASEY, Kevin Michael
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    Secrétaire
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    British40906890001
    FORSTER, Ian
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    Secrétaire
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    British37511580001
    GORNALL, John
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    174534770001
    GREENER, Colin Tom
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    British74462200001
    HODGSON, David John
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    British1421500001
    HODGSON, David John
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    183 Queen Alexandra Road
    SR3 1XN Sunderland
    Tyne & Wear
    British1421500001
    MCBURNIE, Alan
    11 The Court
    Whickham
    NE16 4HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    11 The Court
    Whickham
    NE16 4HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65832330001
    SCOTT, Thomas Gordon
    23 Belsay Avenue
    NE25 8PY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    23 Belsay Avenue
    NE25 8PY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British39809260001
    SHIPLEY, Julie
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Croft Road
    West Yorkshire
    British155609980001
    WILLIAMS, Gwilym Caisley
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British112895630002
    WILLIAMS, Gwilym Caisley
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    18 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British112895630002
    BASEY, Kevin Michael
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    Administrateur
    The Old School
    NE46 4LN Anick
    Northumberland
    British40906890001
    BLAKEY, Colin
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    133 Eastern Way
    Darras Hall
    NE20 9RH Ponteland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish18947160001
    CROFT, Michael
    14 Whithorn Court
    NE24 5JB Blyth
    Northumberland
    Administrateur
    14 Whithorn Court
    NE24 5JB Blyth
    Northumberland
    British78418730001
    DHIRANI, Sharandeep Kaur
    107 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Ponteland
    Northumberland
    Administrateur
    107 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9LY Ponteland
    Northumberland
    EnglandBritish125654700001
    FORSTER, Ian
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    26 Croftside
    Etherley Park
    DL14 0ST Bishop Auckland
    County Durham
    British37511580001
    FREEMAN, Clive Gregory
    63 Dene Lane
    Fulwell
    SR6 8EH Sunderland
    Tyne And Wear
    Administrateur
    63 Dene Lane
    Fulwell
    SR6 8EH Sunderland
    Tyne And Wear
    British40906940001
    GOULDING, Gerald Peter
    8 Ewesley
    Rickleton
    NE38 9JG Washington
    Tyne & Wear
    Administrateur
    8 Ewesley
    Rickleton
    NE38 9JG Washington
    Tyne & Wear
    British4679250001
    GREENER, Colin Tom
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Glebe Croft 4 Delhi View
    Ryton
    NE40 4QR Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritish74462200001
    GRIFFIN, Angus Macdonald
    8a West Park Road
    Cleadon
    SR6 7RR Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    8a West Park Road
    Cleadon
    SR6 7RR Sunderland
    Tyne & Wear
    British43223950001
    HOPKINSON, Paul Martin
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Great BritainBritish61412160002
    LINDEN, Robert Wallace
    Ardmair
    6 Lowes Fall The Downs
    DH1 4NP Durham
    Administrateur
    Ardmair
    6 Lowes Fall The Downs
    DH1 4NP Durham
    British1421490003
    MCLELLAND, Phillip Alexander
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Croft Road
    Crossflatts
    BD16 2UA Bingley
    Bradford & Bingley Plc
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish138782370001
    MUIRHEAD, Peter
    4 Gladstone Terrace
    Sandyford
    NE2 1AY Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    4 Gladstone Terrace
    Sandyford
    NE2 1AY Newcastle Upon Tyne
    British36273740001

    MNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 déc. 2009
    Livré le 15 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property at gosforth newcastle upon tyne (TY480821) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of England (The Security Trustee)
    Transactions
    • 15 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 août 2008
    Livré le 10 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of England as Security Trustee
    Transactions
    • 10 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2007
    Livré le 12 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over all right title and interest in and to the real property with all buildings fixtures fittings plant and machinery thereon; any goodwill of business and other rights,the investments,intellectual property,shares,dividends and other monies payable; all monetary claims and related rights,proceeds of any insurance,specific contracts,etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of England,as Security Trustee
    Transactions
    • 12 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 olney close cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7 lily avenue bedlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 northolt avenue cramlington northumberland tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1994
    Livré le 13 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    14 westmount killingworth tyne and wear tog with the goodwill of the business and the benefit of all licences held.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 13 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 04 sept. 1992
    Livré le 07 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,180,698.00
    Brèves mentions
    5.048 acres of land at cowpen road blyth northumberland.
    Personnes ayant droit
    • North of England Building Society
    Transactions
    • 07 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 03 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £555,124.00 including further advances
    Brèves mentions
    1.46 acres of land at iolanthe terrace south shields tyne and wear.
    Personnes ayant droit
    • The North of England Building Society
    Transactions
    • 03 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 24 janv. 1992
    Livré le 30 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £938,105.00
    Brèves mentions
    2.035 acres of land at denecroft wylam northumberland.
    Personnes ayant droit
    • North of England Building Society
    Transactions
    • 30 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 28 mars 1991
    Livré le 05 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,754,830-00 and further advances due or to become due form the company to the chargee.
    Brèves mentions
    Seven acres of land at east bailey, killingworth, tyne & wear.
    Personnes ayant droit
    • North of England Building Society.
    Transactions
    • 05 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 26 juil. 1990
    Livré le 11 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • North of England Building Society
    Transactions
    • 11 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0