MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMIDDLE ASTON HOUSE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02507306
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    • Activités combinées de services administratifs de bureau (82110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pera Business Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COLESLAW 186 LIMITED31 mai 199031 mai 1990

    Quels sont les derniers comptes de MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mai 2016

    État du capital au 31 mai 2016

    • Capital: GBP 450,905
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2015

    État du capital au 05 juin 2015

    • Capital: GBP 450,905
    SH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    12 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    21 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Robert Hughes le 01 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2014

    État du capital au 09 juin 2014

    • Capital: GBP 450,905
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de , Pera Innovation Park, Nottingham Road, Melton Mowbray, Leicestershire, LE13 0PB le 28 nov. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    21 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mai 2013 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    22 pagesAA

    Nomination de Mr Peter Robert Hughes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alan Baxter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mai 2012

    1 pagesAA01

    Nomination de Mrs Lorraine Ann Gibson en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Glyn Goddard en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de John Hill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GIBSON, Lorraine Ann
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    Secrétaire
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    168858100001
    HUGHES, Peter Robert
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishDirector88069960003
    WHYSALL, Roger James
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishDirector112096580002
    ASHCROFT, Jonathan
    The Rectory Farmhouse
    Broadwell
    GL56 0TL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Secrétaire
    The Rectory Farmhouse
    Broadwell
    GL56 0TL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British70934810001
    BOX, Christine Barbara
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    Secrétaire
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    British11344490001
    DAVIES, Peter Thomas
    14 Northumberland Road
    CV32 6HA Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    14 Northumberland Road
    CV32 6HA Leamington Spa
    Warwickshire
    British58158320001
    GODDARD, Glyn Peter
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Innovation Park
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Innovation Park
    Leicestershire
    United Kingdom
    BritishFinance Director65451370002
    KEMM, Michael John
    Ruscombe The Green
    Old Dalby
    LE14 3LL Melton Mowbray
    Leicestershire
    Secrétaire
    Ruscombe The Green
    Old Dalby
    LE14 3LL Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary1439640001
    ARMSTRONG, Ronald Akers
    32 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    32 High Street
    Barford
    CV35 8BU Warwick
    Warwickshire
    BritishChief Executive32564920001
    ASHCROFT, Jonathan
    The Rectory Farmhouse
    Broadwell
    GL56 0TL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Rectory Farmhouse
    Broadwell
    GL56 0TL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishFinance Director70934810001
    BAXTER, Alan John
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector182984770001
    BOX, Brian Colin
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    Administrateur
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    BritishManaging Director11344500001
    BOX, Christine Barbara
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    Administrateur
    Middle Aston House
    Middle Aston
    OX5 3PT Oxford
    BritishDirector11344490001
    DAVIES, Peter Thomas
    14 Northumberland Road
    CV32 6HA Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    14 Northumberland Road
    CV32 6HA Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Executive58158320001
    GODDARD, Glyn Peter
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritishChief Financial Officer65451370002
    HILL, John Thomas
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Pera Innovation Park
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritishChief Executive164725450001
    KEMM, Michael John
    Ruscombe The Green
    Old Dalby
    LE14 3LL Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Ruscombe The Green
    Old Dalby
    LE14 3LL Melton Mowbray
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary1439640001
    LITTLEDALE, Robert Wheatley
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Highfield The Slade
    Charlbury
    OX7 3SJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishDirector1450690001
    PEARSON, Joy Fairhurst
    Linden Cottage
    Witney Lane Leafield
    OX8 5PG Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Linden Cottage
    Witney Lane Leafield
    OX8 5PG Witney
    Oxfordshire
    BritishCompany Director56891240001
    THOMAS, Julian Morgan
    28 Joiners Road
    Three Crosses
    SA4 3NY Swansea
    Administrateur
    28 Joiners Road
    Three Crosses
    SA4 3NY Swansea
    BritishCompany Director61976660001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Pera International
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    England
    06 avr. 2016
    Nottingham Road
    LE13 0PB Melton Mowbray
    Pera Business Park
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Guarantee Without Share Capital
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement00412652
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    MIDDLE ASTON HOUSE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 13 mars 2008
    Livré le 26 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Present and future assets to the extent any such present and future assets are a security asset. The property being f/h land k/a middle aston house middle aston t/no ON141378. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anthony John Tuckley, John Thomas Hill, John Watson Bennett, Thomas Philip Sowden and Glyn Peter Goddard (Each a Trustee and Together the Trustees)
    Transactions
    • 26 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2008
    • 01 avr. 2008
    • 06 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental legal charge
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 07 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a rose cottage and orchard cottage middle aston oxfordshire and all buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1992
    Livré le 06 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rose cottage and orchard cottage middle aston oxfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 21 janv. 1992
    Livré le 24 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H rose cottage and orchard cottage middle aston oxfordshire described in a conveyance dated 21/01/1992 made between spillers limited and the company together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 25 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings k/a middle aston house middle aston, oxford as comprise in a conveyance dated 5/2/91.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 21 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 févr. 1991
    Livré le 11 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land together with the house & buildings thereon comprised in a conveyance dated 5/2/91.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0