ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02508326
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    • (6603) /

    Où se situe ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KILN COTESWORTH STEWART LIMITED 18 mars 199718 mars 1997
    KILN COTESWORTH MEMBERS AGENCY LIMITED06 janv. 199406 janv. 1994
    KILN MEMBERS AGENCY LIMITED29 juin 199029 juin 1990
    FLOWFACTOR LIMITED04 juin 199004 juin 1990

    Quels sont les derniers comptes de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juil. 2012

    7 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Fountain House C/O Argenta Private Capital Limited, 130 Fenchurch Street London EC3M 5DJ le 05 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 juil. 2011

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Ian Taylor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2011

    État du capital au 24 janv. 2011

    • Capital: GBP 500,200
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Fiona Ann Blood le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur William David Robson le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Robert Robson le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Antony John Smithson le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Auburn Cowing Taylor le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Milka Jacoby le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Michael Colcomb le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher John Rupert Fairs le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Paul Flach le 21 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2009 au 30 juin 2010

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    17 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    7 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    British81668440001
    BLOOD, Fiona Ann
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    Administrateur
    32 Vale Road
    KT10 0NJ Claygate
    Surrey
    EnglandBritish75768690001
    BRAY, Jeremy Mark
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    Administrateur
    The High Beeches
    Handcross
    RH17 6QH West Sussex
    EnglandBritish23885670002
    COLCOMB, Andrew Michael
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    128 High Street
    Hadleigh
    IP7 5EL Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish81668440001
    FAIRS, Christopher John Rupert
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    Administrateur
    6 Tufa Close
    Walderslade Woods
    ME5 9LU Chatham
    Kent
    United KingdomBritish63723860002
    FLACH, Robert Paul
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    Administrateur
    4 Old Hatch Manor
    HA4 8QG Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritish253187050001
    JACOBY, Milka
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    Administrateur
    14 Park Way
    Shenfield
    CM15 8LH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish29062500001
    ROBSON, John Robert
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    Melbourne Stud
    Ayton Green
    AL6 9BB Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish24465330001
    ROBSON, William David
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Woods
    Hatfield Broadoak
    CM22 7BU Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish7309190001
    SMITHSON, Antony John
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    1 Cardwell Crescent
    Sunninghill
    SL5 9AW Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish16035440001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Secrétaire
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    British4866920001
    AITCHISON, Peter John
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Upper Weston House
    Cot Lane, Chidham
    PO18 8SU Chichester
    West Sussex
    British3693350002
    BONNER, Alan James
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Widdington Hall Church Lane
    Widdington
    CB11 3SF Saffron Walden
    Essex
    British36779200001
    BUTLER, Roy Joseph
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Heydour,24 Glebe Road
    Purley On Thames
    RG8 8DP Reading
    Berkshire
    England
    British39597150001
    COMBE, Kenneth Christian
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Ashlands Court
    SN16 9SR Malmesbury
    Wiltshire
    British3787020003
    DANN, David Linton
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    Administrateur
    Cuppes House Bells Lane
    Hoo
    ME3 9HT Rochester
    Kent
    British8646650001
    DUNKLEY, Christopher Leslie
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Knowle Hill House
    Ulcombe
    ME17 1ES Maidstone
    Kent
    EnglandBritish7932240001
    FLEMING-WILLIAMS, Robert Andrew
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    Administrateur
    13 Woodborough Road
    SW15 6DY London
    United KingdomBritish173325840001
    GABB, Anthony Hugh Samuel
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    Administrateur
    Updown House
    Hook Heath Road
    GU22 0QF Woking
    Surrey
    United KingdomBritish72717340002
    GILBART SMITH, Brian Martin
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Coach House Twyford Road
    Waltham St Lawrence
    RG10 0HE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish46668550001
    GRAVES, Adrian George
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    EnglandUnited Kingdom36906810001
    GREEN, Jonathan Napier
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    Administrateur
    7 Earls Court Gardens
    SW5 0TD London
    United KingdomBritish60228850001
    HARPER, Robert John
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Little Puxted
    Brenchley
    Tonbridge
    Kent
    British23885690001
    JUDD, Christopher
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Tendrings Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LT Saffron Walden
    Essex
    British63845020002
    KAUNTZE, Ralph Anthony Charles
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    Administrateur
    Hansford House
    EX37 9ES Umberleigh
    North Devon
    British14338500002
    MARSHALL, Denis Alfred, Sir
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    Redways
    Warfleet Road
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British105410001
    SHARP, Anthony Arthur Vivian
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Rookhurst House Colwell Lane
    RH17 7SR Haywards Heath
    West Sussex
    British40355820001
    SHIPTON, John Keith
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    Administrateur
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    EnglandBritish65780490001
    SOUTH, Anthony Ian Godfrey Charles
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Reightons, Houghton Green Lane
    Playden
    TN31 7PJ Rye
    East Sussex
    British32778400003
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, Ian Auburn Cowing
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Cottage Sandpit Hall Road
    Chobham
    GU24 8HA Woking
    Surrey
    United KingdomBritish4866920001
    TAYLOR, John Joseph
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    Administrateur
    14 The Grove
    DA6 8HF Bexleyheath
    Kent
    British3787030001
    WHITEHURST, David
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    Administrateur
    31 Sawyers Grove
    CM15 9BD Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish3693340001

    ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 04 août 1998
    Livré le 07 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit and all such rights to the repayment thereof as the company may at any time have under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement premier interest account 7024118.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 sterling borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 03 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A revolving loan facility in an aggregate amount of £100,000,000 or its equivalent from time to time in us dollars
    Brèves mentions
    The trustees charge, by way of first floating charge, if and to the extent that such assets are or are liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 03 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge ("the deed") and made between the names and trustees (each defined therein) constituting the syndicate 33 1998 dollar borrowing group as chargors, hiscox syndicates limited and credit suisse first boston (the "bank") as chargee
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 03 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A revolving loan facility in an aggregate amount £100,000,000 or it's equivalent from time to time in us dollars
    Brèves mentions
    The trustees charge, by way of first floating charge if and to the extent that such assets are or liable in the future to become comprised in that part of the trust fund of the name in relation to which the managing agent has power to give directions all those particulars as detailed on form M395.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 03 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ANTON PRIVATE CAPITAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juil. 2011Commencement of winding up
    08 janv. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0