EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED

EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02509250
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Zenith Building 5th Floor 26
    Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAYMODE LIMITED06 juin 199006 juin 1990

    Quels sont les derniers comptes de EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 14 déc. 2010

    11 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 sept. 2010

    16 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kroll Limited the Observatory Chapel Walks Manchester M2 1HL le 25 juin 2010

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 mars 2010

    20 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 sept. 2009

    28 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 mars 2009

    25 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    38 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMISON, William Andrew
    Town Fold
    Marple Bridge
    SK6 5BT Stockport
    3
    Cheshire
    Secrétaire
    Town Fold
    Marple Bridge
    SK6 5BT Stockport
    3
    Cheshire
    British131067820001
    WARD, John Joseph
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    Secrétaire
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    BritishDirector129750460001
    WARD, John Joseph
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    Administrateur
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    BritishDirector129750460001
    GRAHAM, Howard Buchanan
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    Secrétaire
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    BritishFinance Consultant27666470003
    KARATZIA, Gillian
    30 Albion Gardens Close
    Royton
    OL2 6PW Oldham
    Lancashire
    Secrétaire
    30 Albion Gardens Close
    Royton
    OL2 6PW Oldham
    Lancashire
    British84680010001
    NIEWIADOMSKI, David
    8 Birches Way
    Kidsgrove
    ST7 4XU Newcastle
    Staffordshire
    Secrétaire
    8 Birches Way
    Kidsgrove
    ST7 4XU Newcastle
    Staffordshire
    BritishAccountant99483550001
    PARRY, Martyn James
    19 Greencroft Meadow
    Royton
    OL2 6LQ Oldham
    Secrétaire
    19 Greencroft Meadow
    Royton
    OL2 6LQ Oldham
    BritishCommercial Finance Director97878140002
    TELFORD, Robert George
    1 Madryn Street
    L8 3TT Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    1 Madryn Street
    L8 3TT Liverpool
    Merseyside
    British14014160001
    YOUNG, Philip Denham
    Royal Lodge
    20 Bolton Road
    CH62 5DN Port Sunlight
    Merseyside
    Secrétaire
    Royal Lodge
    20 Bolton Road
    CH62 5DN Port Sunlight
    Merseyside
    British135004010001
    AUGUSTO, Luis Venancio Batalha
    55 Mansfield Close
    Birchwood
    WA3 6QN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    55 Mansfield Close
    Birchwood
    WA3 6QN Warrington
    Cheshire
    PortugueseCompany Director14014190001
    DICKENS, Geoffrey
    10 Sherwood Grove
    Helsby
    WA6 0BF Frodsham
    Cheshire
    Administrateur
    10 Sherwood Grove
    Helsby
    WA6 0BF Frodsham
    Cheshire
    BritishCompany Director80244560002
    GRAHAM, Howard Buchanan
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    Administrateur
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    BritishFinance Consultant27666470003
    GRAHAM, Howard Buchanan
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    Administrateur
    17 Lancaster Road
    Birkdale
    PR8 2LF Southport
    Lancashire
    BritishFinance Consultant27666470003
    HEY, Pamela
    66 Buckstones Road
    OL2 8DN Shaw
    Lancashire
    Administrateur
    66 Buckstones Road
    OL2 8DN Shaw
    Lancashire
    BritishSales Director100033430001
    LUND, Annika Susanne
    55 Mansfield Close
    Birchwood
    WA3 6QN Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    55 Mansfield Close
    Birchwood
    WA3 6QN Warrington
    Cheshire
    SwedishCompany Director14014170001
    PARRY, Martyn James
    19 Greencroft Meadow
    Royton
    OL2 6LQ Oldham
    Administrateur
    19 Greencroft Meadow
    Royton
    OL2 6LQ Oldham
    United KingdomBritishCommercial Finance Director97878140002
    PHOENIX, Mark
    35 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Manchester
    Administrateur
    35 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Manchester
    BritishTechnical Director99839750001
    SMITH, Robert
    5 Lydcott
    NE38 8TN Washington
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 Lydcott
    NE38 8TN Washington
    Tyne & Wear
    BritishProject Manager99483500001
    TELFORD, Robert George
    1 Madryn Street
    L8 3TT Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    1 Madryn Street
    L8 3TT Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director14014160001
    WARD, John Joseph
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    Administrateur
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    BritishDirector129750460001
    WARD, John Joseph
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    Administrateur
    1 Cwrt Y Groes
    Tyn-Y-Groes
    LL32 8TZ Conwy
    Groesynyd House
    Gwynedd
    BritishDirector129750460001
    YOUNG, Philip Denham
    Royal Lodge
    20 Bolton Road
    CH62 5DN Port Sunlight
    Merseyside
    Administrateur
    Royal Lodge
    20 Bolton Road
    CH62 5DN Port Sunlight
    Merseyside
    United KingdomBritishDirector135004010001
    YOUNG, Philip Denham
    37 Waterpark Road
    CH42 8PN Birkenhead
    Merseyside
    Administrateur
    37 Waterpark Road
    CH42 8PN Birkenhead
    Merseyside
    BritishDirector35061090001
    YOUNG, Philip Denham
    37 Waterpark Road
    CH42 8PN Birkenhead
    Merseyside
    Administrateur
    37 Waterpark Road
    CH42 8PN Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director35061090001

    EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 mars 2007
    Livré le 28 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Memorandum of deposit
    Créé le 15 août 2005
    Livré le 20 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed charge the stocks shares bonds debenture notes or other securities of any kind whatsoever all dividends distributions interest and other income paid or made all accreditations of a capital nature from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 30 juil. 2004
    Livré le 03 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the shares and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 24 avr. 2003
    Livré le 07 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and awg residential finance limited and prestigious living (halifax) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the shares and the derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mai 2000
    Livré le 31 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a groesynyd hospital conwy north wales t/no: WA861324.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 mai 2000
    Livré le 19 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 oct. 1998
    Livré le 13 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the east side of nant-y-glyn colwyn bay clywd t/no.WA851004. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 1998
    Livré le 14 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and including a loan of £135,000
    Brèves mentions
    F/H property k/a groesynyd hospital conwy gwynedd.
    Personnes ayant droit
    • Helmsley Acceptances Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General form of debenture
    Créé le 10 févr. 1998
    Livré le 14 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Groesynyd hospital conwy gwynedd (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Helmsley Acceptances Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 oct. 1996
    Livré le 10 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1993
    Livré le 12 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings k/a summerhill buile hill salford greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 avr. 1993
    Livré le 30 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EURO MARKETING (NORTH WEST) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2010Administration ended
    03 sept. 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Scott Gaillie
    The Observatory Chapel Walks
    M2 1HL Manchester
    practitioner
    The Observatory Chapel Walks
    M2 1HL Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Observatory Chapel Walks
    M2 1HL Manchester
    practitioner
    The Observatory Chapel Walks
    M2 1HL Manchester
    Simon Wilson
    Kroll
    The Observatory
    M2 1HL Chapel Walks
    Manchester
    practitioner
    Kroll
    The Observatory
    M2 1HL Chapel Walks
    Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0