CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02513051
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    • (7487) /

    Où se situe CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    Adresse du siège social
    Suite 309 New Loom House
    101 Back Church Lane
    E1 1LU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHEVIOT ARTUS PLC30 nov. 199930 nov. 1999
    CHEVIOT ARTUS OCCUPATIONAL HEALTH PLC07 oct. 199807 oct. 1998
    CHEVIOT CONSULTANCY LIMITED24 juil. 199024 juil. 1990
    FLAXWAY LIMITED18 juin 199018 juin 1990

    Quels sont les derniers comptes de CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesMG02
    AKLD4GO0

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01
    ATHLYFZH

    legacy

    3 pages363a
    XBIMAD98

    legacy

    7 pages395
    ARLNW7R3

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA
    LAP8U6YQ

    legacy

    2 pages403a
    AXF6Z23W

    legacy

    3 pages363a
    X7POY0N2

    legacy

    4 pages395
    A2NHKYPN

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 août 2006

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    legacy

    2 pages363a

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cheviot artus PLC\certificate issued on 22/05/06
    2 pagesCERTNM

    Qui sont les dirigeants de CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ASHCROFT, Peter David
    37 Teal Court
    Herons Reach
    FY3 8FT Blackpool
    Lancashire
    Secrétaire
    37 Teal Court
    Herons Reach
    FY3 8FT Blackpool
    Lancashire
    British81743930002
    GONZALEZ, George Augustine
    Hill House
    Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Hill House
    Deepdene Park Road
    RH5 4AW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director34772880001
    GOUGH, Ralph Edward, Mr
    28 Aldebert Terrace
    SW8 1BJ London
    Administrateur
    28 Aldebert Terrace
    SW8 1BJ London
    United KingdomBritishCompany Director40616600003
    KOMONDOUROS, Markos
    Saray Arkasi Sok No 28 (Apt 12)
    Gumussuyu
    Istanbul
    Turkey
    Secrétaire
    Saray Arkasi Sok No 28 (Apt 12)
    Gumussuyu
    Istanbul
    Turkey
    British67903250002
    ROBINSON, Christopher Eric
    The Fold
    3-4 City Lane
    HX3 5LE Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Fold
    3-4 City Lane
    HX3 5LE Halifax
    West Yorkshire
    British46736630002
    TOBIN, Anya
    59b Charlton Church Lane
    Charlton
    SE7 7AE London
    Secrétaire
    59b Charlton Church Lane
    Charlton
    SE7 7AE London
    BritishMarketing97170450003
    LONGFORD HOPE AND COMPANY (ACCOUNTANTS) LTD
    Coniston Cold
    BD23 4EA Skipton
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Coniston Cold
    BD23 4EA Skipton
    North Yorkshire
    66307070001
    ARTUS, Karen Mary
    The Cedars Crescent Road
    RG1 5SL Reading
    Administrateur
    The Cedars Crescent Road
    RG1 5SL Reading
    CanadianDirector62616910001
    GREGORY, Peter Andrew
    3 Gainsborough Court
    BD23 1QG Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Gainsborough Court
    BD23 1QG Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishNone83025370001
    GREGORY, Peter Andrew
    3 Gainsborough Court
    BD23 1QG Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Gainsborough Court
    BD23 1QG Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector83025370001
    KOMONDOUROS, Markos
    Saray Arkasi Sok No 28 (Apt 12)
    Gumussuyu
    Istanbul
    Turkey
    Administrateur
    Saray Arkasi Sok No 28 (Apt 12)
    Gumussuyu
    Istanbul
    Turkey
    BritishBanking67903250002
    LOCK, Darren John, Dr
    82 Ziggurat
    Saffron Hill
    EC1N 8QX London
    Administrateur
    82 Ziggurat
    Saffron Hill
    EC1N 8QX London
    BritishDirector57357580004
    THOMAS, William Bentley Chedzoy
    1 Hillview Crescent
    GU2 8BG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    1 Hillview Crescent
    GU2 8BG Guildford
    Surrey
    BritishMarketing76545710001
    WILLIAMS, Janet Mary
    98e Stuart Court Richmond Hill
    TW10 6RJ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    98e Stuart Court Richmond Hill
    TW10 6RJ Richmond
    Surrey
    BritishHealth Care Consultant12117060003

    CHEVIOT ARTUS (SKIPTON) PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 25 févr. 2009
    Livré le 28 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2008
    Livré le 08 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 07 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Legal & equitable mortgage over land & immovable assets, fixed charge over other assets & rights.
    Personnes ayant droit
    • Qx Factoring Services Limited
    Transactions
    • 07 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge by way of debenture
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 nov. 2000
    Livré le 17 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 17 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 févr. 2000
    Livré le 01 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0