INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED

INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02519916
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cardale House Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ZONEFILL LIMITED09 juil. 199009 juil. 1990

    Quels sont les derniers comptes de INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2021

    3 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2020

    3 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Cecil Edward Parkinson en tant que directeur le 22 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 sept. 2015

    État du capital au 30 sept. 2015

    • Capital: GBP 418,455
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Cardale House Cardale Park Beckwith Head Road Harrogate North Yorkshire HG3 1RY à Cardale House Cardale Court Beckwith Head Road Harrogate North Yorkshire HG3 1RY le 25 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2014

    État du capital au 11 juil. 2014

    • Capital: GBP 418,455
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Central House Beckwith Knowle Otley Road Harrogate North Yorkshire HG3 1UG* le 10 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KABERRY, Andrew Murdoch Scott
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    British1646020001
    KABERRY, Andrew Murdoch Scott
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director1646020002
    WILKINSON, Peter Robert
    Sycamore Cottage Barrowby Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Sycamore Cottage Barrowby Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HD Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director4373790001
    JAMES, Richard Mark
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Nether End House
    Barnsley Road
    HD8 8YG Denby Dale
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector77966860001
    MCGRATH, Melvyn
    6 Low Moor Hall
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    Administrateur
    6 Low Moor Hall
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    BritishDirector6460100001
    PARKINSON, Cecil Edward, The Rt Hon The Lord
    The Old Vicarage
    Northaw
    EN6 4NZ Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Northaw
    EN6 4NZ Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director67100190003
    SLINGER, John Malcolm
    Westfield House
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Westfield House
    Carr Lane Thorner
    LS14 3HD Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director4365920002
    SYKES, Paul
    Duck House
    Studley Roger
    HG4 3AY Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Duck House
    Studley Roger
    HG4 3AY Ripon
    North Yorkshire
    BritishDirector61689210001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Holf Technologies Limited
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Cardale Court
    Beckwith Head Road
    HG3 1RY Harrogate
    Cardale House
    North Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Autorité légaleEngland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    INTEGRATED TECHNOLOGY (EUROPE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 09 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any f/h or l/h property; fixtures; proceeds of sale; fixed and floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transactions
    • 09 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 31 juil. 2003
    Livré le 19 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land k/a nidderdale house being the land lying to the south of ottley road pannal t/no NYK49264 and f/h land k/a the land at harlow 2000 and being land on the south side of cardale park pannal t/no NYK257598. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Wilkinson
    Transactions
    • 19 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 juil. 2003
    Livré le 31 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage, all that freehold land known as nidderdale house and being the land lying to the south of otley road, pannal t/n NYK49264 all that freehold land known as the land at harlow 2000 and being land on the south side of cardale park, pannal t/n NYK257598. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 09 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transactions
    • 09 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 déc. 1999
    Livré le 06 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Office premises cawood house beckwith knowle harrowgate north yorkshire t/n NYK49264.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 31 août 1999
    Livré le 09 sept. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 05 juil. 1999
    Livré le 07 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any or all of the company's indebtedness due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement for ibm global financing dated 30TH june 1999 and in relation to the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transactions
    • 07 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 01 sept. 1995
    Livré le 02 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods for the time being outstanding at any time during the existence of this charge
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note no. 1644 by the chargee to the company. The proceeds of sale of the goods held by the company in the capacity of commission agent. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 23 août 1995
    Livré le 25 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods for the time being outstanding at any time during the existence of this charge
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note no.1639 By the chargee to the company. The proceeds of sale of the goods held by the company in the capacity of commission agent. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC.,
    Transactions
    • 25 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 16 août 1995
    Livré le 19 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note no.1638. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC
    Transactions
    • 19 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 09 août 1995
    Livré le 17 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note no 1637 by the chargee to the company, the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC
    Transactions
    • 17 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 09 juin 1995
    Livré le 13 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note no 1584 the proceeds of sale etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC
    Transactions
    • 13 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Notice of retention of title
    Créé le 24 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any contracts for the sale of goods
    Brèves mentions
    The goods supplied under delivery note.1562 Dated 24TH may 1995 by the chargee to the company ("the goods"). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The City (Europe) PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture deed
    Créé le 18 avr. 1995
    Livré le 26 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 26 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0