ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02522258
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    • (9220) /

    Où se situe ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Berkshire House
    168-173 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALL 3 MEDIA INTERNATIONAL LIMITED08 déc. 200308 déc. 2003
    CHRYSALIS TELEVISION INTERNATIONAL LIMITED30 oct. 199630 oct. 1996
    CHRYSALIS DISTRIBUTION LIMITED08 févr. 199408 févr. 1994
    CHRYSALIS HOME VIDEO LIMITED30 août 199030 août 1990
    TIMERANDOM LIMITED16 juil. 199016 juil. 1990

    Quels sont les derniers comptes de ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    legacy

    pages652a

    Comptes annuels établis au 31 août 2008

    pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 comp act 06 12/01/2009
    RES13

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288c

    legacy

    pages288c

    legacy

    pages288c

    Comptes annuels établis au 31 août 2007

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Certificat de changement de nom

    Company name changed all 3 media international limite d\certificate issued on 31/08/07
    pagesCERTNM

    legacy

    pages288c

    Comptes annuels établis au 31 août 2006

    pagesAA

    legacy

    pages287

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages403a

    legacy

    pages403a

    legacy

    pages288c

    legacy

    pages155(6)a

    legacy

    pages155(6)a

    legacy

    pages403a

    legacy

    pages395

    legacy

    pages288a

    Comptes annuels établis au 31 août 2005

    pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Secrétaire
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    British93412530001
    BURNS, Julian Delisle
    Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    16
    Administrateur
    Chesterford Gardens
    Hampstead
    NW3 7DE London
    16
    United KingdomBritish17986720005
    MORRISON, Stephen Roger
    34 Hampstead Grove
    NW3 6SR London
    Administrateur
    34 Hampstead Grove
    NW3 6SR London
    United KingdomBritish63326820002
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Administrateur
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritish93412530001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    BLESSYN, Julie
    147(B) Holland Road
    West Kensington
    W14 8AS London
    Administrateur
    147(B) Holland Road
    West Kensington
    W14 8AS London
    British43311930001
    PILSWORTH, Michael John
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    Administrateur
    Glebe House
    Church Lane
    LU6 2DJ Eaton Bray
    Bedfordshire
    British82502160001
    SHARMAN, Mark Brian
    Heatherlands
    Salisbury Road Ower
    SO51 6EE Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Heatherlands
    Salisbury Road Ower
    SO51 6EE Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish100171690001
    SPURGEON, Christopher Nigel
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Administrateur
    91 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    United KingdomBritish95569230001
    WATKINS, Nicholas Revely
    Pennireve 5 Akehurst Street
    Roehampton
    SW15 5DR London
    Administrateur
    Pennireve 5 Akehurst Street
    Roehampton
    SW15 5DR London
    British41696760001
    WILLOUGHBY, Christina
    47 Crown Road
    St Margarets
    TW1 3EJ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    47 Crown Road
    St Margarets
    TW1 3EJ Twickenham
    Middlesex
    British68591600001
    WOHLGEMUTH, John Richard Steven
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    Administrateur
    48d Primrose Hill Road
    NW3 3AA London
    British38684180002
    WRIGHT, Christopher Norman
    Flat 2 87 Holland Park
    W11 3RZ London
    Administrateur
    Flat 2 87 Holland Park
    W11 3RZ London
    United KingdomBritish34644910005

    ALL3MEDIA WORLDWIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed to a debenture
    Créé le 28 sept. 2006
    Livré le 06 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed
    Créé le 21 juin 2005
    Livré le 09 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 09 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chrysalis Group PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 août 2003
    Livré le 06 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each group company to the chargee under the terms of the aformentioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0