RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02526071 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?
Adresse du siège social | 60 Newman Street W1T 3DA London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Andrew Charles Thorp le 01 janv. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Charles Thorp le 01 janv. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Charles Canadine en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Deborah Jane Beaven en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Taylor en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Mcbeath en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 15 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Crispin David Farrant Matson le 01 oct. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORP, Andrew Charles | Secrétaire | Lower Downs Road SW20 8QF London 1 England | British | Company Secretary | 92831490001 | |||||
BEAVEN, Deborah Jane | Administrateur | Stourvale Gardens Chandler's Ford SO53 3NE Eastleigh 15 Hampshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 253029090001 | ||||
CANADINE, Stephen Charles | Administrateur | Cheriton Road SO22 5AX Winchester 59 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 141973110001 | ||||
MATSON, Crispin David Farrant | Administrateur | 76 Harpes Road OX2 7QL Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 101327810001 | ||||
THORP, Andrew Charles | Administrateur | Lower Downs Road SW20 8QF London 1 England | England | British | Company Secretary | 92831490002 | ||||
MAY, Peter | Secrétaire | 47 Kingfield Road Ealing W5 1LD London | British | 39936210002 | ||||||
TAYLOR, Martin Graham | Secrétaire | 1 Beech Place AL3 5LQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | 83051190001 | ||||||
RYBKA BATTLE UK LIMITED | Secrétaire | 14-17 Wells Mews W1P 3FL London | 24650890002 | |||||||
ARMSTRONG, Richard | Administrateur | 36 Poplar Plains Crescent M4V 1E8 Toronto Ontario M4v 1e8 Canada | Canadian | Professional Engineer | 75812220001 | |||||
BATH, Brian Arthur | Administrateur | 25 Cavendish Street FOREIGN Toronto Canada | Canadian | Engineer | 1331200001 | |||||
BATTLE, Timothy Quentin | Administrateur | 34 Werter Road Putney SW15 2LJ London | British | Director | 1331190002 | |||||
BRAY, Kevin John | Administrateur | Dormers Brent Road, East Brent TA9 4JG Highbridge Somerset | British | Engineer | 73371170001 | |||||
DRAPER, Marc | Administrateur | 30 Lakeside Crescent EN4 8QJ Barnet Hertfordshire | British | Engineer | 60604240001 | |||||
FISCHER, Norbert Franz | Administrateur | 2510 Robin Drive FOREIGN Mississauga Ontario Canada | Canadian | Engineer | 24648660001 | |||||
MACLEOD, David | Administrateur | 88 Craiglea Drive EH10 5PH Edinburgh | Scotland | British | Engineer | 1331160002 | ||||
MAY, Peter | Administrateur | 47 Kingfield Road Ealing W5 1LD London | British | Accountant | 39936210002 | |||||
MCBEATH, Charles Pryde | Administrateur | 74 Pollard Road Whetstone N20 0UD London | England | British | Chartered Engineer | 68035820001 | ||||
MOTRAN, Hani Louis | Administrateur | 324 Atha Avenue FOREIGN Richmond Hill Ontario Canada | Canadian | Director | 24648610001 | |||||
SMITH, Simon Leslie | Administrateur | Wellbrook Way Girton CB3 0GP Cambridge 24 Cambridgeshire | England | British | Chartered Engineer | 140771060001 | ||||
TAYLOR, Martin Graham | Administrateur | 1 Beech Place AL3 5LQ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | Engineer | 83051190001 | ||||
WOOLLEY, David John | Administrateur | 57 Watermill Close TW10 7UJ Richmond Surrey | British | Engineer | 5112760001 |
RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Créé le 24 sept. 2004 Livré le 25 sept. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions £35,250.00. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 12 août 2003 Livré le 14 août 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 26 oct. 2000 Livré le 03 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti £20,250 from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed and the lease of even date defined therein | |
Brèves mentions All the company's right title benefit and interest in and to the initial deposit of £20,250. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 nov. 1997 Livré le 06 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 27 janv. 1995 Livré le 01 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Premises on 3RD floor at 14-17 (inc:) wells mews l/b of westminster. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 06 déc. 1994 Livré le 08 déc. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 30TH november 1994 | |
Brèves mentions Deposit account held at granville trust mint house 77 mansell street london (£18350.00 rent deposit). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 nov. 1992 Livré le 02 déc. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0