RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED

RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02526071
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    60 Newman Street
    W1T 3DA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RYBKA SMITH GINSLER & BATTLE SCOTLAND LIMITED26 oct. 199026 oct. 1990
    AMBERSTONE ASSOCIATES LIMITED27 juil. 199027 juil. 1990

    Quels sont les derniers comptes de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2014

    État du capital au 03 mars 2014

    • Capital: GBP 42,500
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Andrew Charles Thorp le 01 janv. 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Charles Thorp le 01 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Mr Stephen Charles Canadine en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Deborah Jane Beaven en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Taylor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Mcbeath en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Simon Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Crispin David Farrant Matson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2009

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THORP, Andrew Charles
    Lower Downs Road
    SW20 8QF London
    1
    England
    Secrétaire
    Lower Downs Road
    SW20 8QF London
    1
    England
    BritishCompany Secretary92831490001
    BEAVEN, Deborah Jane
    Stourvale Gardens
    Chandler's Ford
    SO53 3NE Eastleigh
    15
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Stourvale Gardens
    Chandler's Ford
    SO53 3NE Eastleigh
    15
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant253029090001
    CANADINE, Stephen Charles
    Cheriton Road
    SO22 5AX Winchester
    59
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Cheriton Road
    SO22 5AX Winchester
    59
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Engineer141973110001
    MATSON, Crispin David Farrant
    76 Harpes Road
    OX2 7QL Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    76 Harpes Road
    OX2 7QL Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishChartered Engineer101327810001
    THORP, Andrew Charles
    Lower Downs Road
    SW20 8QF London
    1
    England
    Administrateur
    Lower Downs Road
    SW20 8QF London
    1
    England
    EnglandBritishCompany Secretary92831490002
    MAY, Peter
    47 Kingfield Road
    Ealing
    W5 1LD London
    Secrétaire
    47 Kingfield Road
    Ealing
    W5 1LD London
    British39936210002
    TAYLOR, Martin Graham
    1 Beech Place
    AL3 5LQ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Beech Place
    AL3 5LQ St Albans
    Hertfordshire
    United Kingdom83051190001
    RYBKA BATTLE UK LIMITED
    14-17 Wells Mews
    W1P 3FL London
    Secrétaire
    14-17 Wells Mews
    W1P 3FL London
    24650890002
    ARMSTRONG, Richard
    36 Poplar Plains Crescent
    M4V 1E8 Toronto
    Ontario M4v 1e8
    Canada
    Administrateur
    36 Poplar Plains Crescent
    M4V 1E8 Toronto
    Ontario M4v 1e8
    Canada
    CanadianProfessional Engineer75812220001
    BATH, Brian Arthur
    25 Cavendish Street
    FOREIGN Toronto
    Canada
    Administrateur
    25 Cavendish Street
    FOREIGN Toronto
    Canada
    CanadianEngineer1331200001
    BATTLE, Timothy Quentin
    34 Werter Road
    Putney
    SW15 2LJ London
    Administrateur
    34 Werter Road
    Putney
    SW15 2LJ London
    BritishDirector1331190002
    BRAY, Kevin John
    Dormers
    Brent Road, East Brent
    TA9 4JG Highbridge
    Somerset
    Administrateur
    Dormers
    Brent Road, East Brent
    TA9 4JG Highbridge
    Somerset
    BritishEngineer73371170001
    DRAPER, Marc
    30 Lakeside Crescent
    EN4 8QJ Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    30 Lakeside Crescent
    EN4 8QJ Barnet
    Hertfordshire
    BritishEngineer60604240001
    FISCHER, Norbert Franz
    2510 Robin Drive
    FOREIGN Mississauga
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    2510 Robin Drive
    FOREIGN Mississauga
    Ontario
    Canada
    CanadianEngineer24648660001
    MACLEOD, David
    88 Craiglea Drive
    EH10 5PH Edinburgh
    Administrateur
    88 Craiglea Drive
    EH10 5PH Edinburgh
    ScotlandBritishEngineer1331160002
    MAY, Peter
    47 Kingfield Road
    Ealing
    W5 1LD London
    Administrateur
    47 Kingfield Road
    Ealing
    W5 1LD London
    BritishAccountant39936210002
    MCBEATH, Charles Pryde
    74 Pollard Road
    Whetstone
    N20 0UD London
    Administrateur
    74 Pollard Road
    Whetstone
    N20 0UD London
    EnglandBritishChartered Engineer68035820001
    MOTRAN, Hani Louis
    324 Atha Avenue
    FOREIGN Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    324 Atha Avenue
    FOREIGN Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    CanadianDirector24648610001
    SMITH, Simon Leslie
    Wellbrook Way
    Girton
    CB3 0GP Cambridge
    24
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Wellbrook Way
    Girton
    CB3 0GP Cambridge
    24
    Cambridgeshire
    EnglandBritishChartered Engineer140771060001
    TAYLOR, Martin Graham
    1 Beech Place
    AL3 5LQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Beech Place
    AL3 5LQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomUnited KingdomEngineer83051190001
    WOOLLEY, David John
    57 Watermill Close
    TW10 7UJ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    57 Watermill Close
    TW10 7UJ Richmond
    Surrey
    BritishEngineer5112760001

    RYBKA SMITH GINSLER AND BATTLE LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 24 sept. 2004
    Livré le 25 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £35,250.00.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 25 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 août 2003
    Livré le 14 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 oct. 2000
    Livré le 03 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,250 from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed and the lease of even date defined therein
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the initial deposit of £20,250.
    Personnes ayant droit
    • Patricia Ann Allsopp and Michael Edward Ranulph Allsopp,William Paulharriman and Andrew William Kennedy Merriam
    Transactions
    • 03 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 1997
    Livré le 06 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1995
    Livré le 01 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises on 3RD floor at 14-17 (inc:) wells mews l/b of westminster. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 06 déc. 1994
    Livré le 08 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 30TH november 1994
    Brèves mentions
    Deposit account held at granville trust mint house 77 mansell street london (£18350.00 rent deposit).
    Personnes ayant droit
    • Patricia Ann Allsopp,Michael Edward Ranulph Allsopp and William Paul Harriman
    Transactions
    • 08 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1992
    Livré le 02 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0