FILMAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFILMAN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02535268
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FILMAN LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe FILMAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FILMAN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour FILMAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 déc. 2019

    6 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Hellmann Worldwide Logistics Limited Kuhlmann House Lancaster Way Fradley Park Lichfield Staffordshire WS13 8SX à One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham West Midlands B4 6GH le 16 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Dividend 20/11/2018
    RES13

    Nomination de Mr Andrew George Sulston en tant qu'administrateur le 14 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Carsten Fuhlendorf en tant que directeur le 18 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Shares dividends 28/07/2017
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The company declares a dividend of £550,000 in total,in repect of the issued 7,022,569 ordinary shares of £1 each in the capital of the company. 02/05/2017
    RES13

    Nomination de Mr Carsten Fuhlendorf en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthias Simon Emil Magnor en tant qu'administrateur le 01 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Interim dividend 02/12/2016
    RES13

    Cessation de la nomination de Juergen Paul Josef Burger en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    État du capital au 02 déc. 2016

    • Capital: GBP 14,569
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de FILMAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRACE, Nigel
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Secrétaire
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    165608400001
    CONNOR, Andrew
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    EnglandBritish140077640003
    MAGNOR, Matthias Simon Emil
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    GermanyGerman223662650001
    SULSTON, Andrew George
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    EnglandBritish100840520001
    BLETSO, Bryan Edward
    11 Broomfield Park
    RH4 3QQ Westcott
    Surrey
    Secrétaire
    11 Broomfield Park
    RH4 3QQ Westcott
    Surrey
    British50582160004
    COPPER, Ian Duncan
    Baildon
    BD17 6SX Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Baildon
    BD17 6SX Shipley
    West Yorkshire
    British39412640001
    KAUFMAN, Andrew Charles
    15 The Ridgeway
    HA7 4BE Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    15 The Ridgeway
    HA7 4BE Stanmore
    Middlesex
    British1514860001
    LUCAS, Julia Catherine
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    155568130001
    ALKE, Klaus
    Schwanenburg 23
    Osnabruck 4500
    Germany
    Administrateur
    Schwanenburg 23
    Osnabruck 4500
    Germany
    German17962490001
    BURGER, Juergen Paul Josef
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    Administrateur
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    GermanyGerman209156760001
    COPPER, Ian Duncan
    12 St Helier Grove
    Baildon
    BD17 6SX Shipley
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 St Helier Grove
    Baildon
    BD17 6SX Shipley
    West Yorkshire
    British5499510001
    FUHLENDORF, Carsten
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    Administrateur
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    GermanyGerman223663280001
    HELLMANN, Klaus Walter Charles
    Grobelwee 33
    Osnabruck 4500
    FOREIGN
    West Germany
    Administrateur
    Grobelwee 33
    Osnabruck 4500
    FOREIGN
    West Germany
    German17962480001
    JENNINGS, Adrian Mark
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    Administrateur
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    EnglandBritish197275590001
    LOHMEIER, Andreas
    93 Canbury Avenue
    KT2 6JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    93 Canbury Avenue
    KT2 6JR Kingston Upon Thames
    Surrey
    German97180920002
    MARRIOTT, Matthew Stephen
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140077580001
    MEYER, Martin
    15 The Woodlands
    WS13 6XE Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    15 The Woodlands
    WS13 6XE Lichfield
    Staffordshire
    German77876670002
    NEEDLEY, Melvyn John
    Farmer House 40 Farmer Street
    Bradmore
    NG11 6PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Farmer House 40 Farmer Street
    Bradmore
    NG11 6PE Nottingham
    Nottinghamshire
    British24781860004
    WIMMER, Stefan
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Hellmann Worldwide Logistics Limited
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffordshire
    United Kingdom
    GermanyGerman138388690001
    WYATT, Alan Henry
    Rivendell 108 Mount Harry Road
    TN13 3SN Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Rivendell 108 Mount Harry Road
    TN13 3SN Sevenoaks
    Kent
    British56184020001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FILMAN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffs
    England
    06 avr. 2016
    Lancaster Way
    Fradley Park
    WS13 8SX Lichfield
    Kuhlmann House
    Staffs
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03336460
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FILMAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2016
    Livré le 04 août 2016
    En cours
    Brève description
    The freehold land on the north side of lakeside road, colnbrook (title number: BK336675).. The freehold land at plot B4 fradley park, fradley (title number: SF399927).
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 04 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Assignment of rents
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 16 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The rent, other income and all other monies due or to become due from the company to the chargee and its respective successors, assignees and transferees (the beneficiaries) on any account whatsoever under the loan agreement
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to any rents or income or sums derived from or payable to the company arising from the properties whether or not by virtue of the tenancies granted in respect of the property (the rental income) and as further security for the indebtedness all its right title and interest in the rental account and all sums in or credited to such account from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank, London Branch
    Transactions
    • 16 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture, guarantee and indemnity
    Créé le 27 juil. 2001
    Livré le 16 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All such sums of money and all or any other liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the debenture,guarantee and indemnity
    Brèves mentions
    By way of first fixed legal charge all and singular that part of the property described or referred to in the first schedule of the debenture, guarantee and indemnity. By way of first fixed charge all and singular the debts. By way of specific equitable charges all its present and future uncalled capital and such of the property not described in the aforementioned schedule. By way of floating charge all the undertaking and goodwill, intellectual property and all the other property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hamburgische Landesbank, London Branch
    Transactions
    • 16 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 26 août 1999
    Livré le 08 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lakeside road colnbrook buckinghamshire t/n BK336675 all interest in the building contract ,rental account,rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dg Deutsche Genossenschaftsbank Ag
    Transactions
    • 08 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 28 août 1998
    Livré le 02 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land/blds known as land at fradley park,lichfield; t/no SF240889 and SF372758; the proceeds of sale thereof and benefit of covenants for title and any contract and moneys thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dg Bank Deutsche Genossenschaftsbank-London Branch
    Transactions
    • 02 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a land at lakeside road colnbrook buckinghamshire t/no.BK336675. Assigns its interest and benefit in the building contract, the rent account and all rental income and sales proceeds. Floating charge over all undertaking property & assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dg Bank Deutsche Genossenschaftsbank London Branch
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage (customer's account)
    Créé le 30 déc. 1997
    Livré le 08 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from hellmann international forwarders limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Hamilton house, cemetery road, bradford, west yorkshire BD8 8RS title number wyk 118227. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 nov. 1991
    Livré le 09 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property on the north side of lakeside road, colnbrook, bucks. T/no. BM70439. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 09 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FILMAN LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 déc. 2018Commencement of winding up
    16 juil. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0