TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED

TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02537946
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TELEDATA LIMITED03 janv. 199103 janv. 1991
    LUCKFLOW LIMITED07 sept. 199007 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 3 Prenton Way Prenton CH43 3ET à Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL le 08 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 déc. 2015

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2015

    État du capital au 04 mars 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2014

    État du capital au 17 mars 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Nomination de Michael Howard Davies en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Janet Reid en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Janet Dorothy Reid en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Marie Ross en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Lewis Wark le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Marie Isobel Ross le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIES, Michael Howard
    c/o Scottish Power Ltd
    Atlantic Quay, Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Scottish Power Ltd
    Atlantic Quay, Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Scotland
    British168272680001
    VENMAN, Marion
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Administrateur
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    ScotlandBritish125700460002
    WARK, David Lewis
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Administrateur
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    ScotlandBritish46723000002
    DOBBIE, William
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    British107339410001
    GREGG, Rhona
    25 Lammermuir Wynd
    ML9 1UT Larkhall
    Lanarkshire
    Secrétaire
    25 Lammermuir Wynd
    ML9 1UT Larkhall
    Lanarkshire
    British111591600001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    2 Darluith Park
    PA5 8DD Brookfield
    Renfreshire
    Secrétaire
    2 Darluith Park
    PA5 8DD Brookfield
    Renfreshire
    British77939460002
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secrétaire
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MCCULLOCH, Alan William
    4 Dumbrock Road
    Strathblane
    G63 9EF Glasgow
    Secrétaire
    4 Dumbrock Road
    Strathblane
    G63 9EF Glasgow
    British66601950003
    MCPHERSON, Donald James
    14 Braid Drive
    Cardross
    G82 5QD Dumbarton
    Dunbartonshire
    Secrétaire
    14 Braid Drive
    Cardross
    G82 5QD Dumbarton
    Dunbartonshire
    British40519810004
    MCSWEEN, Angus
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    British50499250001
    MORTIMER, James
    43 Highburgh Drive
    Rutherglen
    G73 3RR Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    43 Highburgh Drive
    Rutherglen
    G73 3RR Glasgow
    Lanarkshire
    British27374660001
    REID, Janet Dorothy
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1 Atlantic Quay
    Scotland
    Secrétaire
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1 Atlantic Quay
    Scotland
    British157091210001
    ROSS, Marie Isobel
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    Secrétaire
    c/o Scottish Power
    Atlantic Quay
    Robertson Street
    G2 8SP Glasgow
    1
    British42057170004
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Administrateur
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    BERRY, Charles Andrew
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish109780690001
    COCHRANE, Keith Robertson
    15 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    Administrateur
    15 Brompton Terrace
    PH2 7DQ Perth
    Perthshire
    British105823620001
    DOBBIE, William
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107339410001
    DUFFIELD, Sheelagh Jane
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    Administrateur
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    ScotlandBritish52720790003
    HADDOW, Neil Scott
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    Administrateur
    104 Mearns Road
    Clarkston
    G76 7UP Glasgow
    British53774190001
    HEASLEY, John
    17 Lawmarnock Crescent
    PA11 3AS Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    17 Lawmarnock Crescent
    PA11 3AS Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British100717000001
    HUNTER, David William
    The Old Stables
    Home Farm
    RG25 2JZ Hackwood Farm
    Basingstoke, Hampshire
    Administrateur
    The Old Stables
    Home Farm
    RG25 2JZ Hackwood Farm
    Basingstoke, Hampshire
    EnglandBritish101929840001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British74872510003
    MCALOON, William Gerard
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    Administrateur
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    British108756350001
    MCLEAN, Gregory Joseph
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    Administrateur
    3 Princes Terrace
    Dowanhill
    G12 9JW Glasgow
    American33612180002
    MCSWEEN, Angus
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish50499250001
    NISH, David Thomas
    Kiloran
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    Administrateur
    Kiloran
    Houston Road
    PA13 4NY Kilmacolm
    ScotlandBritish57316940002
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003
    STANLEY, Rupert James
    New School Farm
    6 Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    New School Farm
    6 Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    UkBritish50448490001

    TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 sept. 1993
    Livré le 28 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mercury Communications (Enterprises) Limited
    Transactions
    • 28 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 1993
    Livré le 25 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TELEDATA (OUTSOURCING) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2015Commencement of winding up
    30 sept. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    practitioner
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Restructuring Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    practitioner
    Kpmg Restructuring Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0