WATERPAPER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATERPAPER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02538266
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATERPAPER LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe WATERPAPER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pentagon Island
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WATERPAPER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REEVE (DERBY) LIMITED19 mars 199119 mars 1991
    MATCHTODAY LIMITED10 sept. 199010 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de WATERPAPER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WATERPAPER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Amount of £850000 is capitalised 02/07/2018
    RES14
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    État du capital après une attribution d'actions au 02 juil. 2018

    • Capital: GBP 1,000,000
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 02 juil. 2018

    • Capital: GBP 100
    3 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Graham Peter Hall en tant que directeur le 30 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ian Thomas Oakes en tant que directeur le 04 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert Gordon Truscott en tant qu'administrateur le 27 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Trevor John Reeve en tant que directeur le 02 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Lewis en tant qu'administrateur le 01 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Nomination de Andrew Barrie Welch en tant qu'administrateur le 14 août 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Ian Thomas Oakes en tant qu'administrateur le 14 août 2017

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2016

    État du capital au 11 avr. 2016

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WATERPAPER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, David
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    WalesWelsh204030070001
    TRUSCOTT, Robert Gordon
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    EnglandBritish237658990001
    WELCH, Andrew Barrie
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish236848360001
    FLINN, Andrew Dennis
    Goldcrest Drive
    Spondon
    DE21 7TN Derby
    18
    Derbyshire
    Secrétaire
    Goldcrest Drive
    Spondon
    DE21 7TN Derby
    18
    Derbyshire
    British53818900001
    MOTORS SECRETARIES LIMITED
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    Secrétaire
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    50844980002
    MOTORS SECRETARIES LIMITED
    6th Floor Thavies Inn House
    3-4 Holborn Circus
    EC1N 2HA London
    Secrétaire
    6th Floor Thavies Inn House
    3-4 Holborn Circus
    EC1N 2HA London
    50844980001
    BARRETT, Dean Michael
    66 Broadwater Avenue
    SG6 3HJ Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    66 Broadwater Avenue
    SG6 3HJ Letchworth
    Hertfordshire
    British1305990001
    BURROWS, Steven Richard
    205 Broom Lane
    S60 3NW Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    205 Broom Lane
    S60 3NW Rotherham
    South Yorkshire
    British71895270001
    FLINN, Andrew Dennis
    Goldcrest Drive
    Spondon
    DE21 7TN Derby
    18
    Derbyshire
    Administrateur
    Goldcrest Drive
    Spondon
    DE21 7TN Derby
    18
    Derbyshire
    EnglandBritish53818900001
    GLADWIN, Peter William
    Lakeside Lodge
    79 Wedgwood Avenue Blakelands
    MK14 5JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lakeside Lodge
    79 Wedgwood Avenue Blakelands
    MK14 5JZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British26965400002
    HALL, Graham Peter
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    EnglandBritish60418750003
    HALL, Graham Peter
    39 Arundel Drive
    Carlton In Lindrick
    S81 9DL Worksop
    Nottinghamshire
    Administrateur
    39 Arundel Drive
    Carlton In Lindrick
    S81 9DL Worksop
    Nottinghamshire
    British60418750001
    HARVEY, John
    146 Altrincham Road
    SK9 5NQ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    146 Altrincham Road
    SK9 5NQ Wilmslow
    Cheshire
    British1306000001
    HUGHES, David Wesley
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    EnglandBritish192784940001
    OAKES, Ian Thomas
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Nottingham Road
    DE21 6HB Derby
    Pentagon Island
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish91046610002
    REEVE, Susan Lesley
    66 Common Lane
    Tickhill
    DN11 9UF Doncaster
    Yorkshire
    Administrateur
    66 Common Lane
    Tickhill
    DN11 9UF Doncaster
    Yorkshire
    British50549660001
    REEVE, Trevor John
    66 Common Lane
    Tickhill
    DN11 9UF Doncaster
    Yorks
    Administrateur
    66 Common Lane
    Tickhill
    DN11 9UF Doncaster
    Yorks
    EnglandBritish2364070001
    MOTORS DIRECTORS LIMITED
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    Administrateur
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    69096550002
    MOTORS DIRECTORS LIMITED
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    Administrateur
    4 Chiswell Street
    EC1Y 4UP London
    69096550002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WATERPAPER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Reeve Derby Limited
    Chiswell Street
    EC1Y 4UQ London
    10
    England
    06 avr. 2016
    Chiswell Street
    EC1Y 4UQ London
    10
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Acts 1985-2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WATERPAPER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1998
    Livré le 16 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land and buildings on the south side of derby road stretton burton on trent staffordshire by way of fixed charge all gross rents licence fees and other monies receivable in respect of or arising out of any lease of the property the. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1998
    Livré le 05 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage l/h property comprising car showroom and garage premises situate on the north east side of park road oldham t/n-GM30335, LA339412, GM535099 and GM780023 and any part or parts of it and including all rights attached or appurtenant and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it and belonging to the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1998
    Livré le 06 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a unit 1A chadderton industrial estate greengate chadderton t/n GM677659 and all buildings fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 avr. 1998
    Livré le 25 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H & l/h land on the west side of stores road derby derbyshire t/nos DY265058 and DY231535 fixed charge over the plant machinery and fixtures & fittingsthe furniture furnishings equipment tools and other chattels and future goodwill of any business.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 1994
    Livré le 11 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £60,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H property situate at the junction of stores road with cut lane derby t/no. DY231535 and all that f/h of the same property and all equipment and all book debts uncalled captal goodwill patents and undertaking property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Vauxhall Motors Limited
    Transactions
    • 11 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 25 oct. 1994
    Livré le 27 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with any financing agreement or plan and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptances Corporation (U.K.) PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1994
    Livré le 02 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with any financing agreement or plan and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Property on the west side of stores road, derby t/no: DY231535. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Motors Acceptance Corporation (U.K) PLC
    Transactions
    • 02 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 1992
    Livré le 09 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 1992
    Livré le 31 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All those assets specified in the schedule to the debenture dated 30/1/92.
    Personnes ayant droit
    • Shell U.K. Limited
    Transactions
    • 31 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 15 mars 1991
    Livré le 29 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Vauxhall Motors Limited
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0