MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED

MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02538780
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    • (5010) /

    Où se situe MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIDENT MOTOR COMPANY LIMITED11 sept. 199011 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    14 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    4 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    16 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    11 pagesWU07

    Cessation de la nomination de Nicholas Martin Samuel May en tant que directeur le 30 mars 2017

    2 pagesTM01

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    12 pagesWU07

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:annual progress report for period up to 28/04/2016
    8 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:joint liquidators' annual report 07/06/13 - 06/06/14
    8 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur

    2 pages4.31

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Avis d'ordonnance du tribunal pour mettre fin à l'administration

    13 pages2.33B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 07 déc. 2012

    14 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    17 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * 4 St. Giles Court Southampton Street Reading Berkshire RG1 2QL* le 07 août 2012

    1 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * M L G House Blackwater Way Aldershot Hampshire GU12 4DN* le 29 mai 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Jeffs en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    4 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Louise May en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 sept. 2011

    État du capital au 12 sept. 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAY, Louise Janet
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    Secrétaire
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    British58032980003
    PICKLES, Elizabeth
    1 Illingworth Drive
    Bradshaw
    HX2 9RR Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Illingworth Drive
    Bradshaw
    HX2 9RR Halifax
    West Yorkshire
    British3462350001
    SLY, Robin
    10 Hillside Road
    Camelsdale
    GU27 3RL Haslemere
    Surrey
    Secrétaire
    10 Hillside Road
    Camelsdale
    GU27 3RL Haslemere
    Surrey
    British96306510001
    WISEMAN, Shalom David
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    Secrétaire
    2 Woodville Gardens
    Ealing
    W5 2LG London
    British32990150001
    COOK, Kevin Walter
    14 Denton Row
    Holywell Green
    HX4 9BX Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    14 Denton Row
    Holywell Green
    HX4 9BX Halifax
    West Yorkshire
    British20130630001
    JEFFS, Michael Peter
    Pine Tops
    School Lane Lower Bourne
    GU10 3PF Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Pine Tops
    School Lane Lower Bourne
    GU10 3PF Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish45208030006
    MAY, Nicholas Martin Samuel
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    Administrateur
    Cowick Farm
    Hilmarton
    SN11 8RZ Calne
    Wiltshire
    EnglandBritish3462360002
    RIMELL, Tony John
    Penrith Road
    RG21 8XE Basingstoke
    21
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Penrith Road
    RG21 8XE Basingstoke
    21
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish55415300004

    MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge on vehicle stocks
    Créé le 02 juil. 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all new and used motor vehicles,by way of first fixed charge all proceeds of sale, all insurance monies, all debts under the terms of any sale, all the rights title and interest in and the benefit including the right to receive rent hire charges or any other payments of all contracts, the benefit of all guarantee indemnities and securities, all debts under the terms of or in relation to the contracts, all rights enforcing the contracts and all guarantees indemnities and securities . by way of first fixed charge all such of the present and future propery and assets - rent hire charges etc, vehicles leased hired or sold, contracts deposited , title and interest, proceeds, insurance monies, benefits of guarantees indemnites and securities, debts, enforcement rights.
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 20 nov. 2008
    Livré le 22 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 22 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 août 2008
    Livré le 12 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rci Financial Services Limited
    Transactions
    • 12 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 mai 1997
    Livré le 23 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1995
    Livré le 07 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Renault Financial Services Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mars 1992
    Livré le 18 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nws Trust Limited
    Transactions
    • 18 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 06 févr. 1992
    Livré le 10 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MILL LANE ENGINEERING (ALDERSHOT) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juin 2012Administration started
    07 juin 2013Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Taylor
    Pinnacle Building 20 Tudor Road
    RG1 1NH Reading
    Berkshire
    practitioner
    Pinnacle Building 20 Tudor Road
    RG1 1NH Reading
    Berkshire
    James William Stares
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    2
    DateType
    16 sept. 2020Conclusion of winding up
    21 mai 2013Petition date
    07 juin 2013Commencement of winding up
    04 mars 2021Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Taylor
    Pinnacle Building 20 Tudor Road
    RG1 1NH Reading
    Berkshire
    practitioner
    Pinnacle Building 20 Tudor Road
    RG1 1NH Reading
    Berkshire
    James William Stares
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    practitioner
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Nicholas Stewart Wood
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YC London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0