SSR (2012) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSSR (2012) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02539944
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SSR (2012) LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SSR (2012) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SSR (2012) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SMITH, STUART & REYNOLDS LIMITED17 sept. 199017 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de SSR (2012) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour SSR (2012) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 oct. 2012

    État du capital au 12 oct. 2012

    • Capital: GBP 999
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 172 Obelisk Rise Northampton NN2 8TX United Kingdom le 12 oct. 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Cottage Farm Sywell Northampton Northamptonshire NN6 0BJ le 12 oct. 2012

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable précédente prolongée du 31 août 2011 au 29 févr. 2012

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Simon James Smith en tant que directeur le 17 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Carolyn Mary Wheeler le 17 sept. 2011

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Felicity Jane Gardner en tant que directeur le 16 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Nicola Ann Beers en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Matthew Tongue en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Lennox Edmond Thomson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon James Smith le 17 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Felicity Jane Gardner le 17 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2008

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SSR (2012) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHEELER, Carolyn Mary
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Secrétaire
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    BritishOffice Manager75715650001
    BEERS, Nicola Ann
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Administrateur
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor162022420001
    THOMSON, Lennox Edmond
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Administrateur
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor61688110001
    TONGUE, William Matthew
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    Administrateur
    Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    172
    United Kingdom
    EnglandBritishFarm Business Consultant116053840001
    SMITH, Charles David
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Secrétaire
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    British19065850005
    ALDERSON, David Alan
    12 Trinity Avenue
    NN2 6JJ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    12 Trinity Avenue
    NN2 6JJ Northampton
    Northamptonshire
    BritishTown Planner117386170001
    BARNEY, Henry Francis
    54 High Street
    Brigstock
    NN14 3HA Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    54 High Street
    Brigstock
    NN14 3HA Kettering
    Northamptonshire
    BritishChartered Surveyor70674480001
    GARDNER, Felicity Jane
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishTown Planner47098360001
    HAIGH, Pamela Anne
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    BritishTown Planner56057730003
    PASKE, Norman Charles
    Longbrook Farm
    Thurning
    PE8 5RG Peterborough
    Administrateur
    Longbrook Farm
    Thurning
    PE8 5RG Peterborough
    United KingdomBritishChartered Surveyor25273770003
    REYNOLDS, Robert
    Wash Hill Cottage Wash Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Wash Hill Cottage Wash Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JA High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishPlanning And Development Consu10206910002
    ROBERTS, Pamela Mary
    14 The Ridgeway
    LE16 7HQ Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    14 The Ridgeway
    LE16 7HQ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishTown Planner75715470001
    SMITH, Charles David
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Horseblock
    The Green Staverton
    NN11 6JB Daventry
    Northamptonshire
    BritishPlanning And Development Consu19065850005
    SMITH, Simon James
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Cottage Farm
    Sywell
    NN6 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishTown Planning102203990001
    STUART, Robert Ian
    Treetops
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Treetops
    Seven Leaze Lane, Edge
    GL6 6NJ Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritishPlanning And Development Consu73193480001
    THOMSON, Lennox Edmond
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    Administrateur
    172 Obelisk Rise
    NN2 8TX Northampton
    EnglandBritishChartered Surveyor61688110001
    WHITMORE, Marcus Paul
    8 Grasmere Road
    Longlevens
    GL2 0NQ Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    8 Grasmere Road
    Longlevens
    GL2 0NQ Gloucester
    Gloucestershire
    BritishTown Planner56057750001

    SSR (2012) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 nov. 2001
    Livré le 17 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 mars 1995
    Livré le 14 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee s
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charles David Smith
    • Robert Ian Stuart
    • Robert Edward Reynolds
    Transactions
    • 14 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 06 avr. 1994
    Livré le 15 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 1991
    Livré le 07 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transactions
    • 07 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0