GRADESOUND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRADESOUND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02544381
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRADESOUND LIMITED ?

    • Autres services de restauration (56290) / Hébergement et restauration

    Où se situe GRADESOUND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GRADESOUND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SKETCHLEY PROPERTIES LIMITED18 févr. 199118 févr. 1991
    TRUSHELFCO (NO. 1656) LIMITED28 sept. 199028 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de GRADESOUND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GRADESOUND LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GRADESOUND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 mars 2015

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Brian Robert Mackie en tant que directeur le 18 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kris Paul Ludo Geysels en tant qu'administrateur le 18 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 oct. 2014

    État du capital au 09 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Daniel Henry Abrahams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Willis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2013

    État du capital au 07 oct. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian Mackie le 01 mai 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Greenwood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Helen Margaret Willis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Roe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Brian Mackie en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Mark Whiteling en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Qui sont les dirigeants de GRADESOUND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    EnglandBritish183822370001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    BelgiumBelgian193655140001
    BOND GUNNING, Rufus Gordon
    Amesdell
    7b High Street, Bramley
    GU5 0HB Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Amesdell
    7b High Street, Bramley
    GU5 0HB Guildford
    Surrey
    British79529250001
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secrétaire
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163172450001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    WILLIAMS, Richard
    53 Sherwood Avenue
    UB6 0PQ Greenford
    Middlesex
    Secrétaire
    53 Sherwood Avenue
    UB6 0PQ Greenford
    Middlesex
    British10259560001
    BOND GUNNING, Rufus Gordon
    Amesdell
    7b High Street, Bramley
    GU5 0HB Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Amesdell
    7b High Street, Bramley
    GU5 0HB Guildford
    Surrey
    British79529250001
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Administrateur
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritish143546010001
    COLLIVER, Howard Francis
    30 Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    30 Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    United KingdomBritish39780590001
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Administrateur
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritish20511010001
    INGRAM, David
    10 Coniston Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7JU Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    10 Coniston Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7JU Crewe
    Cheshire
    British11652930001
    MACARTNEY, Alan
    Brierfield 176 Hitchin Road
    SG15 6SD Arlesey
    Bedfordshire
    Administrateur
    Brierfield 176 Hitchin Road
    SG15 6SD Arlesey
    Bedfordshire
    British68039590001
    MACKIE, Brian Robert
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritish173446330002
    MAY, Brian Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    EnglandBritish49698960004
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    PILGRIM, Ian
    2 Tythe Gardens
    Stewkley
    LU7 0HF Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    2 Tythe Gardens
    Stewkley
    LU7 0HF Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British10618910001
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish51264250001
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish101297630001
    WILLIAMS, David Michael
    Bunzl Plc
    110 Park Street
    W1K 6NX London
    Administrateur
    Bunzl Plc
    110 Park Street
    W1K 6NX London
    British12672070005
    WILLIAMS, Richard
    53 Sherwood Avenue
    UB6 0PQ Greenford
    Middlesex
    Administrateur
    53 Sherwood Avenue
    UB6 0PQ Greenford
    Middlesex
    British10259560001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritish277089380001

    GRADESOUND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed (relating to the debenture dated 1ST july 1991)
    Créé le 20 sept. 1995
    Livré le 09 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facility agreement and the overdraft facility (as defined) or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(The Agent)
    Transactions
    • 09 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 juil. 1991
    Livré le 09 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the facility agreement and the overdraft facility (as defined)
    Brèves mentions
    (See doc M94 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, the Banks and the Overdraft Bankfor Itself and as Agent and Trustee on Behalf Of
    Transactions
    • 09 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GRADESOUND LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2015Commencement of winding up
    22 mars 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0