OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02545971
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    • (2222) /

    Où se situe OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane
    N20 0YZ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VERTIS DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED28 déc. 200028 déc. 2000
    OLWEN DIRECT MAIL LIMITED13 nov. 199013 nov. 1990
    DRAMBURY LIMITED04 oct. 199004 oct. 1990

    Quels sont les derniers comptes de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mai 2013

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2010

    5 pages4.68

    Avis de constitution du Comité de liquidation

    2 pages4.48

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2008

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 sept. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    7 pages4.68

    Avis de constitution du Comité de liquidation

    2 pages4.48

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    8 pages2.34B

    Résultat de la réunion des créanciers

    35 pages2.23B

    Certificat modifié de constitution du comité des créanciers

    1 pages2.26B

    Déclaration des affaires

    11 pages2.16B

    Qui sont les dirigeants de OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    British35333200002
    DIXON, Nicolas William
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    Administrateur
    3 Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish24161370007
    TAYLOR, Richard Scott
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    The Stables Church Lane
    Dingley
    LE16 8PG Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish35333200002
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Secrétaire
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Secrétaire
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    British122903010001
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Secrétaire
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    HOWARD, John
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    Secrétaire
    714 Avila Drive
    Davidsonville
    Maryland 21035
    America
    American107278560001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003
    ANGELSON, Mark Alan
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Administrateur
    876 Park Avenue
    Penthouse North
    10021 New York
    Usa
    Usa54679960003
    BULL, Dianne
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    37 Copthorne Road
    KT22 7ED Leatherhead
    Surrey
    British25261110001
    COLLINS, John Patrick
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    6 Gorse Cottages
    Hammer Lane Bramshott Chase
    GU26 6DD Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish26864100001
    CROFT, Peter
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    Administrateur
    2 Edgewood Green
    Shirley
    CR0 7PT Croydon
    United KingdomBritish36010140002
    DRAKE, Ian Alexander
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    Administrateur
    1 Palace Green
    Addington
    CR0 9AJ Croydon
    Surrey
    British7119890002
    DURBIN, Dean
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    Administrateur
    19001 Windsor Forest Road
    Mount Airy
    Maryland 21771
    Usa
    American81110710001
    EPPS, Gillian Margaret
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    Administrateur
    1a Hill Road
    CR4 2HS Mitcham
    Surrey
    British23569370001
    FISHER, Angus William Murray
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    Administrateur
    Coledown House
    Vicarage Lane, Curdridge
    S032 2DP Southampton
    Hants
    United KingdomBritish122903010001
    FLANNERY, Christopher James
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    Administrateur
    2809 Boston Street
    Appartment 409
    IRISH Baltimore
    Usa
    British30670590004
    FOOKES, Richard
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    Administrateur
    3 Hereford Drive
    Kings Ore
    CM7 9FX Braintree
    Essex
    British81522540001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Administrateur
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HEALY, Scott
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Mount Pleasant
    MK17 9EX Stoke Hammond
    Buckinghamshire
    British79690160001
    HINDLEY, Martyn John
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    Administrateur
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    EnglandBritish134332760001
    HOLMES, Matthew Willis
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    Administrateur
    Flat 2 19 Cleveland Road
    Barnes
    SW13 0AA London
    British43176290001
    LAYBOURNE, David Andrew
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    Administrateur
    9 Regency Mews
    BR3 2FG Beckenham
    Kent
    British30670600001
    MARTINDALE, Peter
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    Administrateur
    Exeter Mansions
    106 Shaftesbury Avenue
    W1D 5EQ London
    British109116080001
    PONCIA, Kevin Peter
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    Administrateur
    23 Gibraltar Rise
    TN21 8HL Heathfield
    East Sussex
    British39046370001
    REILLY, Edward Thomas
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Administrateur
    62 North Sylvan Road
    06880 Westport
    Connecticut
    Usa
    Usa62916050001
    RIVETT, Peter Christopher
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    Administrateur
    Motte Place Walton Manor
    Walton Street
    KT20 7SA Walton On The Hill
    Surrey
    United KingdomBritish105827610001
    ROLAND, Donald Edward
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    Administrateur
    4 Norwood Road
    Annapolis
    Maryland 21401
    Usa
    American71621920001
    ROOSEN, Adriaan Henri Dominique Marie
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Administrateur
    Stationsweg 26
    Oosterbeek
    6861 Eh
    Netherlands
    Dutch74228750001
    RUDDLE, Andrew Daniel
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    Administrateur
    The Barn Sunt Farm
    Caterfield Lane Staffhurst Wood
    RH9 ORR Oxted
    Surrey
    British20560270002
    SHERWIN, Theodore Daniel
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Administrateur
    338 The Great Road
    Princeton
    FOREIGN Usa Nj 08540
    Usa62915610001
    STEEL, Angus Kennedy
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Brewery Cottage
    Brockhampton
    GL54 5XQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British62259790003

    OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 25 oct. 2005
    Livré le 26 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property assets business undertaking and rights fixed or floating including mortgaged property plant and machinery property rights debts trusts accounts securities intellectual property goodwill contracts insolvency act realisations vat recoveries cash and stock-in-trade.
    Personnes ayant droit
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transactions
    • 26 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 juin 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 11 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other credit party to the chargee or any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its right, title and interest in and to each of the following assets; th properties and all related rights; the debts; the equipment; the intellectual property; all present and future goodwill and all rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation (For Itself and as Agent for the Lenders) (the Agent)
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due from any chargor to the chargees under or in connection with a). The credit agreement b). Any other credit document to which the chargor is party from time to time and c). The debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank (The "Collateral Agent")
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 nov. 1996
    Livré le 03 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 mai 1995
    Livré le 27 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 27 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 mai 1991
    Livré le 17 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OLWEN DIRECT MARKETING SERVICES (CROYDON) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 mai 2006Administration started
    18 sept. 2006Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    practitioner
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    2
    DateType
    18 sept. 2006Commencement of winding up
    12 sept. 2013Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    practitioner
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    practitioner
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    Barry David Lewis
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London
    practitioner
    Harris Lipman
    2 Mountview Court
    N20 0YZ 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0