ISC COMPUTERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéISC COMPUTERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02546296
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ISC COMPUTERS LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication

    Où se situe ISC COMPUTERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ISC COMPUTERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ISC COMPUTERS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ISC COMPUTERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesSH20
    S4YEBGVT

    État du capital au 22 janv. 2016

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19
    A4YCYF1U

    legacy

    2 pagesCAP-SS
    S4YEBGXD

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    App for striking off approved, dir sign DS01 send to ch 18/12/2015
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 18/12/2015
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    L4MVOLD4

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2015

    État du capital au 21 oct. 2015

    • Capital: GBP 61,445
    SH01
    X4IHBNHK

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Mark Kelway Doye le 16 sept. 2015

    2 pagesCH01
    X4G34LSQ

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    16 pagesAA
    L3M3MT0Y

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04
    A3KGFMFN

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04
    A3KGFMEZ

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04
    A3KGFMDV

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 oct. 2014

    État du capital au 06 oct. 2014

    • Capital: GBP 61,445
    SH01
    X3HY3P3V

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 05 oct. 2013

    17 pagesRP04
    A35GETL7

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04
    A3567GRL

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04
    A3567GRD

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04
    A3567GR5

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04
    A3567GQX

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04
    A3567GQP

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2013

    État du capital au 17 avr. 2014

    • Capital: GBP 61,445
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    17 avr. 2014A second filed AR01 was registered on 17/04/2014
    X2IILX1L

    Cessation de la nomination de Simon Lawless en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X2HIA2YJ

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    16 pagesAA
    L2GLN2HK

    Cessation de la nomination de Steven Lamey en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X1NMQPC8

    Qui sont les dirigeants de ISC COMPUTERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROSS, Timothy Lloyd
    Chiddingfold
    N12 7EY London
    30
    England
    Secrétaire
    Chiddingfold
    N12 7EY London
    30
    England
    British160717220001
    DOYE, Philip Mark Kelway
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    EnglandBritishDirector25807380003
    LAWS, Daniel Andrew
    Forest Drive
    BR2 6EE Orpington
    47
    England
    Administrateur
    Forest Drive
    BR2 6EE Orpington
    47
    England
    United KingdomBritishManaging Director166735770001
    PEPPERALL, Henry Brian
    Hydethorpe Road
    Balham
    SW12 0JF London
    115
    England
    Administrateur
    Hydethorpe Road
    Balham
    SW12 0JF London
    115
    England
    EnglandBritishFinance Director50952930006
    COMPTON, Craig Brian
    Croye Close
    SP10 3AF Andover
    Badgers Oak, 23
    Hampshire
    Secrétaire
    Croye Close
    SP10 3AF Andover
    Badgers Oak, 23
    Hampshire
    British157550810001
    MARSHALL, Brian
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    Secrétaire
    112 Hills Road
    CB2 1PH Cambridge
    British76205930002
    RANDALL, Gary Simon
    Station Road
    Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Brook Farm
    Cambridgeshire
    England
    Secrétaire
    Station Road
    Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Brook Farm
    Cambridgeshire
    England
    BritishFinance Director37992680003
    SANCASTER, Stephen John
    3 Teasel Close
    Eaton Socon St Neots
    PE19 4AP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    3 Teasel Close
    Eaton Socon St Neots
    PE19 4AP Huntingdon
    Cambridgeshire
    British68744620001
    BASS, Jason Stuart
    Harradine Close
    Woodhurst
    PE28 3BU Huntingdon
    3
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Harradine Close
    Woodhurst
    PE28 3BU Huntingdon
    3
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTechnical Director157214910001
    COMPTON, Craig Brian
    Croye Close
    SP10 3AF Andover
    Badgers Oak, 23
    Hampshire
    Administrateur
    Croye Close
    SP10 3AF Andover
    Badgers Oak, 23
    Hampshire
    EnglandBritishDirector148088760001
    GUMBLEY, Paul Michael
    Hawthorns
    Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Hawthorns
    Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManaging Director28709330001
    LAMEY, Steven
    Waterside
    HP5 1QF Chesham
    523
    England
    Administrateur
    Waterside
    HP5 1QF Chesham
    523
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer170780460001
    LAWLESS, Simon Mark
    Main Street
    Frolesworth
    LE17 5EG Lutterworth
    Rosedale House
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Main Street
    Frolesworth
    LE17 5EG Lutterworth
    Rosedale House
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritishDirector155778780001
    NORMAN, Tracy Jane
    26 Bernard Road
    PE28 4RW Brampton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    26 Bernard Road
    PE28 4RW Brampton
    Cambridgeshire
    BritishMarketing Director79197430002
    RANDALL, Gary Simon
    Station Road
    Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Brook Farm
    Cambridgeshire
    England
    Administrateur
    Station Road
    Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Brook Farm
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritishFinance Director37992680003
    RANDALL, Nigel Steven
    13 Cambridge Close
    SG18 9SH Langford
    Bedfordshire
    Administrateur
    13 Cambridge Close
    SG18 9SH Langford
    Bedfordshire
    EnglandBritishSales Director100248930001
    SANCASTER, Stephen John
    3 Teasel Close
    Eaton Socon St Neots
    PE19 4AP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    3 Teasel Close
    Eaton Socon St Neots
    PE19 4AP Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishOperations Director68744620001

    ISC COMPUTERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All assets debenture
    Créé le 22 déc. 2010
    Livré le 04 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 04 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 22 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title or interest in or to any credit balance see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H 13 blackstone road stukeley meadows industrial estate huntington cabridgeshire huntingdonshire CB107078. L/h 15 blackstone road stukeley meadows industrial estate cambridgeshire huntingdonshire CB113669. L/h 17 blackstone road stukeley meadows industrial estate cambridgeshire huntingdonshire CB118267 please see MGO1 for further properties fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 janv. 2006
    Livré le 07 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the hawthorns, mill common, huntingdon t/no. CB87262.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 08 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold property known as unit 2 stukeley business centre blackstone road huntingdon cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 2000
    Livré le 04 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 3 stukeley business centre blackstone road huntingdon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 mars 2000
    Livré le 22 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 1998
    Livré le 30 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 1 stuckeley business centre blackstone road huntingdon cambridgeshire t/n CB113669.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 07 avr. 1995
    Livré le 19 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a solar house, stukeley business centre huntingdon cambridgeshire t/no: CB118267 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 mars 1995
    Livré le 16 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 avr. 1991
    Livré le 09 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Solar house stukeley business centre, huntingdon cambridgeshire.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 30 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0