KEADBY POWER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEADBY POWER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02548042
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEADBY POWER LIMITED ?

    • Production d'électricité (35110) / Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

    Où se situe KEADBY POWER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Keadby Power Station
    P O Box 89 Keadby
    DN17 3AZ Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KEADBY POWER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POPPYGROVE LIMITED12 oct. 199012 oct. 1990

    Quels sont les derniers comptes de KEADBY POWER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KEADBY POWER LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KEADBY POWER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Sally Fairbairn en tant que secrétaire le 01 déc. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Lawrence John Vincent Donnelly en tant que secrétaire le 01 déc. 2014

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 nov. 2014

    État du capital au 03 nov. 2014

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Brandon James Rennet en tant que directeur le 13 mars 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    10 pagesAA

    Nomination de Brandon James Rennet en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Antony Brydon en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    10 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    10 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KEADBY POWER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FAIRBAIRN, Sally
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Secrétaire
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    193193030001
    SMITH, Paul Richard
    Grampian House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Administrateur
    Grampian House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    United KingdomBritishChartered Engineer62067440001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Secrétaire
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    British62794440002
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    31 Hillpark Way
    Blackhall
    EH4 7ST Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    31 Hillpark Way
    Blackhall
    EH4 7ST Edinburgh
    Midlothian
    British62794440001
    DUFTY, Kevan
    29 The Green Hawk Green
    SK6 7HT Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    29 The Green Hawk Green
    SK6 7HT Stockport
    Cheshire
    British89069560001
    HASTINGS, David Gillespie
    25 The Meadows
    Messingham
    DN17 3UD Scunthorpe
    South Humberside
    Secrétaire
    25 The Meadows
    Messingham
    DN17 3UD Scunthorpe
    South Humberside
    British47290770001
    NEWSOME, Michael John
    10 Athol Road
    Bramhall
    SK7 1BS Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    10 Athol Road
    Bramhall
    SK7 1BS Stockport
    Cheshire
    British40874420001
    ADAMS, Christopher George
    72 Westgate
    Hale
    WA15 9BB Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    72 Westgate
    Hale
    WA15 9BB Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Manager35062520001
    ALEXANDER, Fraser Mcgregor
    Green Yetts
    Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Green Yetts
    Doune Road
    FK15 9HR Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritishChartered Accountant65278040002
    BRYDON, Antony Gavin Dominic, Dr
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Administrateur
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    ScotlandBritishGroup Treasurer84781430001
    EASTABROOK, Barbara Kay
    82 St Werburghs Road
    Chorlton Cum Hardy
    M21 0UL Manchester
    Administrateur
    82 St Werburghs Road
    Chorlton Cum Hardy
    M21 0UL Manchester
    BritishFinancial Planning & Treasury Manager26027600001
    FAULKNER, Malcolm George
    14 Sudbury Drive
    Lostock
    BL6 4PP Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    14 Sudbury Drive
    Lostock
    BL6 4PP Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director Energy Divis35560560001
    GOLDSWORTHY, Peter
    Quinque 5 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Quinque 5 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    BritishManaging Director Generation6901020001
    GRAY, David Mclaren
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    Administrateur
    Dykeneuk
    Butterstone
    PH8 0HA Dunkeld
    Perthshire
    ScotlandBritishFinance Director140884530001
    MARCHANT, Ian Derek
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    45 Craigcrook Road
    EH4 3PH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishAccountant29951280003
    MARTIN, James Henry
    Burn Brae House
    East Dron , Bridge Of Earn
    PH2 9HG Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Burn Brae House
    East Dron , Bridge Of Earn
    PH2 9HG Perth
    Perthshire
    BritishChartered Engineer49728730002
    READ, Arnold Wadkin, Dr
    8 Gillespie Road
    EH13 0LL Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    8 Gillespie Road
    EH13 0LL Edinburgh
    Lothian
    BritishCompany Director501810001
    RENNET, Brandon James
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House 200
    Perthshire
    Administrateur
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House 200
    Perthshire
    United KingdomBritishChartered Accountant135521350001
    SIGSWORTH, David, Prof.
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    United KingdomBritishGeneration Director4582280001
    SIGSWORTH, David, Prof.
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    9 Station Road
    EH30 9HY South Queensferry
    West Lothian
    United KingdomBritishManager4582280001
    WILMAN, Graham
    20 Sanderling Close
    Westhoughton
    BL5 2SP Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    20 Sanderling Close
    Westhoughton
    BL5 2SP Bolton
    Lancashire
    BritishElectrical Engineer42205700001
    YOUNG, Alan Moffat
    46 Allan Road
    Killearn
    G63 9QE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    46 Allan Road
    Killearn
    G63 9QE Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director5096340001
    YOUNG, Arnold Roger Alexander
    Lossiehall
    Liff
    DD2 5NJ Dundee
    Administrateur
    Lossiehall
    Liff
    DD2 5NJ Dundee
    BritishManager72341120001

    KEADBY POWER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second supplemental debenture
    Créé le 17 déc. 1992
    Livré le 05 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due fromeach obligor under the terms of any of the finance documents.
    Brèves mentions
    See relevant form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerland
    Transactions
    • 05 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amending agreement
    Créé le 17 déc. 1992
    Livré le 05 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of any of the finance documents
    Brèves mentions
    The following documents 1)the group agreements; 2) the novation agreements; and the parent company guarantee acknowledgement letters.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerland
    Transactions
    • 05 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 09 juin 1992
    Livré le 12 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the the union bank of switzerland as agent and trustee for itself and certain other banks under the terms of this charge as defined.
    Brèves mentions
    By way of assignment, all of the present and future right, title and interest of the company in and to the significant agreements (including without limitation, all monies which at any time may be or become payable to the company pursuant thereto and the proceeds of all claims awards and judgements which may at any time be receivable or received by the company pursuant thereto (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerlandas Agent for Itself and Certain Other Banks
    Transactions
    • 12 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1992
    Livré le 16 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to union bank of switzerland under the terms of the facility agreement and/or any finance documents and this debenture.
    Brèves mentions
    By way of legal mortage all the property as specified in schedule 1 (attached to form 395) together with all buildings and fixtures thereon ,the proceeds of sale of all or any part thereof, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in respect of such covenants. Please see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerland
    Transactions
    • 16 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 26 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Site of the former keadby power station, keadby, humberside.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0