KEADBY POWER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | KEADBY POWER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02548042 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KEADBY POWER LIMITED ?
Adresse du siège social | Keadby Power Station P O Box 89 Keadby DN17 3AZ Scunthorpe North Lincolnshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KEADBY POWER LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KEADBY POWER LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour KEADBY POWER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Sally Fairbairn en tant que secrétaire le 01 déc. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lawrence John Vincent Donnelly en tant que secrétaire le 01 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 mars 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brandon James Rennet en tant que directeur le 13 mars 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2011 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brandon James Rennet en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Antony Brydon en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 10 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2008 | 10 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 10 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2006 | 11 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de KEADBY POWER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRBAIRN, Sally | Secrétaire | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 193193030001 | |||||||
SMITH, Paul Richard | Administrateur | Grampian House 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 62067440001 | ||||
DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secrétaire | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | British | 62794440002 | ||||||
DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secrétaire | 31 Hillpark Way Blackhall EH4 7ST Edinburgh Midlothian | British | 62794440001 | ||||||
DUFTY, Kevan | Secrétaire | 29 The Green Hawk Green SK6 7HT Stockport Cheshire | British | 89069560001 | ||||||
HASTINGS, David Gillespie | Secrétaire | 25 The Meadows Messingham DN17 3UD Scunthorpe South Humberside | British | 47290770001 | ||||||
NEWSOME, Michael John | Secrétaire | 10 Athol Road Bramhall SK7 1BS Stockport Cheshire | British | 40874420001 | ||||||
ADAMS, Christopher George | Administrateur | 72 Westgate Hale WA15 9BB Altrincham Cheshire | England | British | Finance Manager | 35062520001 | ||||
ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Administrateur | Green Yetts Doune Road FK15 9HR Dunblane Perthshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 65278040002 | ||||
BRYDON, Antony Gavin Dominic, Dr | Administrateur | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | Scotland | British | Group Treasurer | 84781430001 | ||||
EASTABROOK, Barbara Kay | Administrateur | 82 St Werburghs Road Chorlton Cum Hardy M21 0UL Manchester | British | Financial Planning & Treasury Manager | 26027600001 | |||||
FAULKNER, Malcolm George | Administrateur | 14 Sudbury Drive Lostock BL6 4PP Bolton Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director Energy Divis | 35560560001 | ||||
GOLDSWORTHY, Peter | Administrateur | Quinque 5 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | Managing Director Generation | 6901020001 | |||||
GRAY, David Mclaren | Administrateur | Dykeneuk Butterstone PH8 0HA Dunkeld Perthshire | Scotland | British | Finance Director | 140884530001 | ||||
MARCHANT, Ian Derek | Administrateur | 45 Craigcrook Road EH4 3PH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | Accountant | 29951280003 | ||||
MARTIN, James Henry | Administrateur | Burn Brae House East Dron , Bridge Of Earn PH2 9HG Perth Perthshire | British | Chartered Engineer | 49728730002 | |||||
READ, Arnold Wadkin, Dr | Administrateur | 8 Gillespie Road EH13 0LL Edinburgh Lothian | British | Company Director | 501810001 | |||||
RENNET, Brandon James | Administrateur | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 135521350001 | ||||
SIGSWORTH, David, Prof. | Administrateur | 9 Station Road EH30 9HY South Queensferry West Lothian | United Kingdom | British | Generation Director | 4582280001 | ||||
SIGSWORTH, David, Prof. | Administrateur | 9 Station Road EH30 9HY South Queensferry West Lothian | United Kingdom | British | Manager | 4582280001 | ||||
WILMAN, Graham | Administrateur | 20 Sanderling Close Westhoughton BL5 2SP Bolton Lancashire | British | Electrical Engineer | 42205700001 | |||||
YOUNG, Alan Moffat | Administrateur | 46 Allan Road Killearn G63 9QE Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Company Director | 5096340001 | ||||
YOUNG, Arnold Roger Alexander | Administrateur | Lossiehall Liff DD2 5NJ Dundee | British | Manager | 72341120001 |
KEADBY POWER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental debenture | Créé le 17 déc. 1992 Livré le 05 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due fromeach obligor under the terms of any of the finance documents. | |
Brèves mentions See relevant form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Amending agreement | Créé le 17 déc. 1992 Livré le 05 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of any of the finance documents | |
Brèves mentions The following documents 1)the group agreements; 2) the novation agreements; and the parent company guarantee acknowledgement letters. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental debenture | Créé le 09 juin 1992 Livré le 12 juin 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the the union bank of switzerland as agent and trustee for itself and certain other banks under the terms of this charge as defined. | |
Brèves mentions By way of assignment, all of the present and future right, title and interest of the company in and to the significant agreements (including without limitation, all monies which at any time may be or become payable to the company pursuant thereto and the proceeds of all claims awards and judgements which may at any time be receivable or received by the company pursuant thereto (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 avr. 1992 Livré le 16 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company to union bank of switzerland under the terms of the facility agreement and/or any finance documents and this debenture. | |
Brèves mentions By way of legal mortage all the property as specified in schedule 1 (attached to form 395) together with all buildings and fixtures thereon ,the proceeds of sale of all or any part thereof, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in respect of such covenants. Please see form 395 for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 juil. 1991 Livré le 26 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Site of the former keadby power station, keadby, humberside. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0